The Royal Gazette / Gazette royale (12/02/22) - Gouvernement du ...

22 févr. 2012 - 506624 BRIKSON COMPUTER CABLING. LTD. .... 650106 The Finish Guy Inc. ...... Blonde & Little Financial Services Ltd Terry Fitzgerald.
337KB taille 39 téléchargements 807 vues
The Royal Gazette

Gazette royale

Fredericton New Brunswick

Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428

Vol. 170

Wednesday, February 22, 2012 / Le mercredi 22 février 2012

Notice to Readers

291

Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line.

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis.

Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372.

Business Corporations Act

Loi sur les corporations commerciales

Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to cancel the registration of extra-provincial corporations

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Notice of decision to dissolve provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to dissolve the following corporations pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the corporations.

Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites corporations.

The Royal Gazette — February 22, 2012 001391 038942 044089 049322 056706 059477 059744 059754 501733 503510 504286 506552 506590 508722 508864 508894 508917 514004 514065 514083 600312 604255 605789 611688 624417 624457 630618 630640 630673 630674 630736 630952 636307 637011 637069 637115 637144 637164 637192 637428 643297 643314 643322 643533 643584 643619 643643 649325 649677 649679 649681 649719 649761 649778 649789 649808 649810 649811 649812 649821 649858 649886 649912 649972 649975 650076 650086 650089 650100 650139 650148 650163 650210 044160 649801

001391 N.B. LTD. 038942 N.B. LTD. 044089 N.-B. LTEE 049322 N.B. LTEE/LTD 056706 N.-B. LTEE 059477 N.-B. INC. 059744 N.B. LTD. 059754 N.B. INC. 501733 N.B. LTD. 503510 N.B. LTD. 504286 NB INC 506552 N.B. INC. 506590 N.B. LTD. 508722 N.B. LTD. 508864 NB Ltd. 508894 N.B. LTD. 508917 N.B. INC. 514004 N. B. Ltd. 514065 N.B. Ltd. 514083 N.B. Inc. 516355 N.B. LTD. 604255 N.B. Ltd. 605789 N.B. Inc. 611688 N.B. Ltd. 624417 NB Corp./ 624417 N.-B. Corp. 624457 N.B. Ltd. 630618 NB INC. 630640 NB Ltd. 630673 N.B. Ltd. 630674 N.B. Ltd. 630736 N.-B. Ltée 630952 N.B. Inc. 636307 NB LTD 637011 N.B. Ltd. 637069 NB Inc. 637115 N.B. Inc. 637144 N.B. Ltd. 637164 N.B. INC. 637192 NB INC. 637428 NB Inc. 643297 N.B. Inc. 643314 NB Inc. 643322 N.B. Ltd. 643533 New Brunswick Corporation 643584 New Brunswick Ltd. 643619 NB Inc. 643643 NB LTD. 649325 NB LTD. 649677 NB Ltd. 649679 N.B. Ltd. 649681 N.B. Inc. 649719 N.B. Inc. 649761 N.B. Ltd. 649778 N.B. Ltd. 649789 N.B. LTD. 649808 N.B. Inc. 649810 N.-B. Inc. 649811 NB Inc. 649812 N.B. Inc. 649821 N.-B. Corp. 649858 N.B. Ltd. 649886 NB INC. 649912 NB LIMITED 649972 NB Inc. 649975 NB Ltd. 650076 NB Inc. 650086 N.B. INC. 650089 N.B. LTD. 650100 N.B. Ltd. 650139 N.B. Inc. 650148 NB INC. 650163 N.B. Ltd. 650210 NB Ltée 650210 NB Ltd. A & M HOLDINGS INC. Abdullah Alsaghir M.D. Professional Corporation 617566 ABER INDUSTRIES INC. 636995 Abiron Enterprises Ltd. 059620 ABOVO CONSTRUCTION INC.

Gazette royale — 22 février 2012

292 617441 ACADIAN STURGEON AND CAVIAR INC. 649690 Accent International Inc. 649614 ACR Framing Ltd. 048730 ADAM CANADA LTD. 650207 AER Industries Inc. 000086 AHE PLUMBING & HEATING LTD. 516334 AKITA (NB) BASEMENT SYSTEMS INC 637068 ALG Holdings Ltd. 630573 ALIGN PEOPLE RESOURCES LTD. 506675 ALL NIGHT ALL DAY INC. 643427 ALL SEA ATLANTIC LTD. 637184 ALREADY RITCHIE PROPERTIES LTD. 624542 Altimed Auto Repair Ltd 630693 AMEYA INTERNATIONAL INC. 047016 AQUILA TECHNOLOGIES INC. 637142 AR.RO Realty Inc. 039104 ATLANTIC CANADIANS HOCKEY CLUB INC./CLUB DE HOCKEY CANADIENS DE L’ATLANTIQUE INC. 511510 ATLANTIC FORESTRY SERVICES LTD. 511550 AUBE’S FOODS LTD. 511472 Audfroid Consultants Ltd. 650167 Ava Capital Markets Canada Ltd. 649758 AVALIS SOLUTIONS LTD. 643692 Avatar Human Resources Consulting Ltd. 643353 Azure Sky Films Inc. 624448 B & M Specialized Automotive Services Inc. 650103 B.A.D.A.S. HOLDINGS INC. 643805 BART GORMAN ENTERPRISES LTD. 051510 BARTHOLOMEW ENTERPRISES INC. 508907 BAYSIDE BULK TERMINAL CORPORATION 001613 BAYSIDE STEVEDORING LTD. 649855 Benji Hawkes Drywall & Crackfill Ltd. 617904 BETCO HAULAGE LTD. 033450 BIRD’S CORNER STORE LTD. 033335 BOUCHARD & FRERES CONSTRUCTION LTEE 506624 BRIKSON COMPUTER CABLING LTD. 637195 BROOKS HOMES LTD. 643441 BRUNO ARSENEAU LIVRAISON INC. 036919 BRUNSWICK ASSOCIATES LTD. 002648 C. & D. CONSTRUCTION LIMITED 617486 C. A. Crawford Insurance Inc. 649892 Callstar Marketing Ltd. 650085 Cambridge Equipment Corp. 649783 Camp à Joe inc. 504365 CAPE HOG FARM INC. 044500 CARCROFT HOLDINGS INC. 649889 Cardwell Compost (Asia) Inc. 636941 Carleton International Ltd 630875 Carleton Listings Inc. 511608 CASTLEHILL PROPERTY MANAGEMENT LTD. 600168 CENTRAL SIDING LTD. 003442 CHALEUR VIEW FARM SYNDICATE LTD. 031645 CHAMCOOK ASSOCIATES LTD. 650078 Chameleon Electronic Security Inc. 059604 CHANCE HARBOUR AQUACULTURE AND FISHERIES INC. 502004 CHAUSSURES JOCELYNE LTEE. 649745 CHDM - Oil Canada Inc. 506711 CHERISHED PET MEMORIAL SERVICES LTD. 501800 CHIASSON AQUACULTURE LTEE 043445 CHIASSON MEUBLES MODERNES LTEE 051610 CHIPPIN & DEWITT ASSOCIATES, INC. 003818 CLOVER CONSTRUCTION LTD. 003950 COATES AND HAINES LTD.

649860 046418 504302 514041 636943 053793 649864 624606 650028 511533 605626 650105 649734 502024 617754 624582 514052 643292 643828 605564 630669 049441 605879 514135 637064 643298 637112 649646 649954 624503 008636 643508 508881 624383 643882 504403 630968 611471 643320 059607 643277 047076 511498 617608 617473 605985 643497 501957 501958 007081 617664 630545 637196 611716 630656 059816 059666 650054 051616 611579 624510

Community First Funeral Home Inc. COMPASS MARINE LIMITED COOL SIDE REFRIGERATION LTD. CORPORATE HEROES INTERNATIONAL INC. CSLB Holdings Ltd. CURRY COVE SALMON LTD. D & C Salvage Ltd. Dan Guimond Auto Sales Inc DCAM Productions Ltd. DEBORAH O’LEARY, M.D. PROFESSIONAL CORPORATION Delphinium Ltée Delta Light Canada Inc. DeLuca Corp. DEPANNEUR CHEZ RACHEL LTEE DEVELOPMENTBOX INC. DION-MAHANEY DRYWALL NB LTD. DOUBLE R FISHERIES LTD. DR. AKMAL GHAFOOR PROFESSIONAL CORPORATION Dr. German W. Blando cp inc. DR. GILBERT DRU CORPORATION PROFESSIONNELLE INC. Dr. J. J. Morales Professional Corporation DR. J.C.W. PARROTT PROFESSIONAL CORPORATION Dr. Jean-François Guité Corporation Professionnelle Inc. DR. RONALD HAREBOTTLE PROF. CORP. DR. SYED AHMED & DR. NAJNEEN AHMED PROF. CORP. DREAM MAKERS RECREATION INC. DURELLE’S PEST MANAGEMENT LTD. Durrani & Webb Holdings Ltd ECKO SOLUTION PLUS INC. Entreprise C.D.G.M. Enterprise Inc. EPICERIE R.H. CLAVETTE INC. EXCELL PERMITS & PILOT VEHICLES LTD. Exigen (Canada), Inc. FAUNE HERITAGE WILDLIFE INC. FOAM FREE DRAUGHT EXPERTS INC. FORESTERIE G.L. INC. Foresterie Robichaud Inc. Fundy Minerals Ltd Future Metal Roofing Inc. G. BOUDREAU HOLDING INC. G. Bourque Deliveries Ltd. G. S. MACDIARMID PROFESSIONAL CORPORATION G.G. VENTURES LTD. G.G.Y. Trucking Ltd. G.K. HOLDINGS LTD. Garage Laurie Inc. GARTH POWER TRUCKING LTD. GEO-MAR INC. GEORGE T. YEAMANS PROFESSIONAL CORPORATION INC. GESTION ACADIENNE LTEE ACADIAN MANAGEMENT LTD Gestion YR Ltée GOLBAD DISTRIBUTION SERVICES LTD Gold Sun Media Inc. Golf 101 Inc. Gordon Sharpe Enterprises Inc. GREAT CIRCLE MARINE SERVICES INC. GREEN SHORES ESTATES INC. Green Water Diving Inc. GTA CONSULTANTS INC. GUYCHEM INC. Hansen International Inc

The Royal Gazette — February 22, 2012 649630 HFHG Consulting Inc. 053811 HIGGINS GENERAL INSURANCE LTD. 053780 HILLDALE POTATO INC. 031608 HORIZON ENTERPRISES LTD. 649820 Hotchkiss Home Furnishings Ltd. 617447 Howard Brook Development Inc. 008236 HOYT’S SEPTIC SERVICES LTD. 008237 HOYT’S SUPERMART LTD. 650075 HRMS Solutions, Inc. 617505 HYDRO CLEAN INC. 611556 I.M.S.G. INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS GROUP INC. 649750 IMT Training Services Inc. 630720 Inevitable Holdings Corp. 649844 INFORMATICS TERAFLOP CENTRAL INC. 631002 Ingallwood Manufacturing Inc 611211 InteliConnect Ltd. 650023 Iron Hill Holdings Ltd. 643394 IT Equipment Xpress Ltd. 649615 J & L ENERGY INC. 031681 J. E. & R. GODIN & FILS LIMITEE 630861 J.A.L. Janitorial Ltd. 649779 JACKY’S BAR INC. 637424 Janus Project Management Services Ltd. 059727 JARROSS INVESTMENTS LTD. 630797 JEANNINE & ROBERT TOURS INC. 611560 Jeremiah Jacobs Ltd. 643285 JJL HOLDING INC. 611646 John D. Boyd Plumbing & Heating Ltd. 053763 JOS S. LEGER & SON TRUCKING LTD. 637235 Joshua Investments Inc. 511476 JPM ENTERPRISES INC. 630686 JSM HOLDINGS INC. 051576 JW Walsh & Son Transportation Services Inc. 013256 K. W. POND LIMITED 514115 K.C. HOWE HOLDINGS LTD. 600074 KA KA GOOSE INC. 605853 KATERA INDUSTRIES INC. 643295 Kings Point Productions Inc. 611472 KNOWLEDGE ATLAS INC. 508895 KRISHNA SAI INC. 649743 KVT TRUCKING INC. 009472 LAIRD’S CONSTRUCTION LTD. 049471 LAM & ASSOCIATES LIMITED 643444 Lan-Bert Homes Development Ltd. 630949 Land and Sea Training Ltd. 511479 LATIF PIZZA & DONAIR LTD. 513202 Les Entreprises R.E.H. Fournier Ltée 013382 LES PRODUCTEURS D’ARBRES DE NOEL CLAIRE-FONTAINE LTEE. 642921 LL BRANCH CONSULTANTS INC. 624193 Logroty Inc. 049480 LOSIER STATION SERVICE LTEE 056766 LOUMAREX INC. 508850 M & W CONTRACTING LTD. 649963 M. J. Roy Foundation NB Inc. 617663 M.S.T. Consulting Inc. 010254 MABIE INVESTMENTS LTD. 637154 MacLeod Agronomics Ltd. 036961 MAK BROTHERS LTD. 650209 MakCass Management Inc. 643737 Marathon Canada Imports Ltd. 010443 MARCHE B. PAULIN LTEE 036897 MARIETTE ENTREPRISES LTEE 051625 MARITIME WATER TREATMENT LTD.

Gazette royale — 22 février 2012

293 624413 639773 059499 011777 010838 650102 038618 617966 624279 600260 030237 041451 617474 637328 600242 511467 011319 650142 511404 637357 502019 630676 504270 513941 637362 514029 649754 012798 053761 649732 649605 511366 650108 649645 649644 059763 508985 013311 036998 649152 624391 611525 013518 637262 611417 650144 605855 041653 617461 637122 508956 643733 643756 013979 046956 014025 014029 014144 650088

Maritime Window Defogger Inc. MaRusCo Enterprise Ltd. MATHIS INSTRUMENTS LTD. MCLEAN’S AUTOMOTIVE LTD. MELANSON PLUMBING & HEATING LTD. Mereah Land Services Ltd. METRO PROCESS SERVERS LTD. MICHAUD HOLDINGS (2005) LTD MICHEL BERUBE FORESTRY INC. MIKKEMA INTERNATIONAL INC. MIRAMICHI FOREST ENTERPRISES LTD. MIRAMICHI TAVERN & CLUB LTD. MISTER RENOVATIONS LTD. MITCHCO WELDING & CONTRACTING INC. Modern Masonry Inc. MOE’S ELECTRIC LTD. MONCTON UNION CENTRE LTD. MSP Drywall Ltée MSSI HOLDINGS INC. Muir Bros. Services Ltd. N.R. HOLDINGS LIMITED New Age Glass Repair Inc. NEWMAN & CO. INC. NORTH STAR HOLDINGS LTD. NORTHUMBERLAND WOODLOT ENTERPRISES INC. OCEAN LEGACY INC. On The Way Gifts & Things Inc. PARK CHEDIK LTD.-PARC CHEDIK LTEE PASSEKEAG PHEASANTS LTD. Perkfection Coffee Ltd. PES Parking Enforcement Solutions Inc. PHYSIO PÉNINSULE INC. PIBM Renovations Inc. PIRET (EDMONTON AVENUE) LEASEHOLD INC. PIRET (NB) HOLDINGS INC. PLASTER ROCK GYPSUM & MANUFACTURING LTD. POINTE-SAPIN AUTO PARTS LTD./ PIECES D’AUTO POINTE-SAPIN LTEE PRECISE SURVEYS LTD. PRECISION EDGE LTD. PREFERRED PAVING AND CONSTRUCTION (2010) LTD. Pro Edge Sports Moncton Ltd. QUACO DUCK FISHERIES LTD. QUALITY SOUND ALARM LTD. R & B Watch & Jewellery Ltd. R YOUNG INDUSTRIAL LIMITED R. Boudreau Tree Trimming Ltd R.L.M. Fisheries Ltd. R.M. WATSON AGRI-CONSULTING LTD. Rebound Holdings Ltd. Remorquage Edmundston Towing Inc. Resto Grec Inc RESTO-BAR LE DECK INC. Richard Development Consulting Inc. RICHARD FARMS LIMITED RIDELL HOLDINGS LTD. RIDGEVIEW ENTERPRISES LTD. RIDGEWOOD FARMS LIMITED RIVIERA CONSTRUCTION LTD./ RIVIERA CONSTRUCTION LTEE S&S LANDSCAPING LTD.

053671 624463 514151 014855 030213 643570 636990 630853 624665 015383 630816 624254 649830 617977 611262 049110 044468 031651 611398 611229 516313 053668 650160 511512 637062 650196 504424 649961 650106 508943 617945 046719 650161 611410 016118 605644 624543 059750 643480 514227 030198 649672 605754 605753 643397 649948 038919 611643 059521 001633 611689 649699 649647 617470 649828 624500 643845 624551 637138 611393 021434

_____________________________________________________

S. & L. REALTY 2000 INC. Saint John Marketers Group Inc. ScarHawk Industries Ltd. SCORPIO INVESTMENTS LTD. Sea-Post Ltd. SHUR-LOCK PARKING AUTHORITY INC. SHUR-WAY INVESTMENTS INC. Silver Maple Developments Inc. SOCIÉTÉ STÉPHANE LOSIER INC. SOUTH BRANCH OROMOCTO LTD. SOUTH DAKOTA URANIUM, INC. SOUTHSIDE MANAGEMENT INC. Speckled Springs Trout Farm Inc. SPRUCEHILL ENTERPRISES LTD. ST-ISIDORE RIDO-DECO LTÉE ST. ANDRE FARMS LTD. St. Ignace Wood Truss Ltd. STAR KEY ENTERPRISES LTD. STEELE VENTURES INC. Sugar House Inc. SULLIVAN LANE FARM LTD. SUPERIOR CONCRETE FINISHING LTD. T & C DUNPHY CONTRACTING LTD. T M T Stable Inc. T-Riple J Holdco Ltd. T.E.R Consulting Inc. TANYA GAYLE ESTATES LTD. THE EMPEROR’S KITCHEN INC. The Finish Guy Inc. The Fishermen’s Anchor Inc. The Gallagher Pub Group Inc. THE KILLAM AGENCY INC. The Reel Review Inc. THE RESULTS COMPANY INC. THERMOFIB LTD./ LTEE THREE GZ INC. THRIFTKING GROUP INC. TONY’S SERVICE STATION (1995) LTD. TOPdesk Canada Corporation Turn of the Century Trolley Tours Inc. U. S. L. RESTORATIONS LTD. Unique Landscaping and Property Management INC. URBAN CONSTRUCTION ATLANTIC LIMITED URBAN DEVELOPMENTS ATLANTIC LIMITED Vanguard Studio Inc. VAPOR GREEN SOLUTION LTD / SOLUTION VAPEUR VERTE LTEE VICKERS POOLS LTD. VISTA BAY MOTORS INC. VU TRUONG RESTAURANT LTD. W. J. BEAIRSTO CO. LTD. W. J. INDUSTRIAL SALES INC. WAKEFORD BUSINESS LTD. Webb & Durrani Holdings Ltd Wee World Inc. WENDOW CORP. West Side Service Center Ltd. Westgate Financial Group Inc. Winchester’s Classic Woman Limited With Power Property Holdings Inc. Wow Now Inc. YOUR CANDLE SHOP LTD.

The Royal Gazette — February 22, 2012 Notice of decision to cancel the registration of extra-provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to cancel the registration of the following extraprovincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may cancel the registration.

624248 637182 636929 073162 649691 649752 649843 643751 624155 077585 018966 077130 647757

2051099 ONTARIO INC. 3101-5837 QUÉBEC INC. 6880061 Canada Ltd. ACME TRUCK LINE, INC. AFS Aerial Photography Inc. AIB INTERNATIONAL CANADA, INC. ATLANTIC CANADA HVAC SERVICES INC. Atlantic Medical Imaging Services Inc. BEN LIVINGSTON AND SONS LIMITED Bristol Group Inc. BUTLER TRUCKING COMPANY COMCARE (CANADA) LIMITED CRS Civilian Regulatory Specialists Inc. / CRS Spécialistes Réglementaires Civil Inc.

Gazette royale — 22 février 2012

294

Avis d’une décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales.

650172 efo Capital Inc. 650079 ÉRABLIÈRE LUC ET CRAIG GAGNON INC 605874 Evans Land Development Limited 600348 FRIENDS OF THE FAMILY ESTATE SERVICES INC. 624274 INTERNATIONAL MUFFLER COMPANY 074556 JEUNIQUE INTERNATIONAL (CANADA) INC. 600542 LASANALTECH INC. 649686 LORBEC METALS LTD. / MÉTAUX LORBEC LTÉE 649635 M & C HESSE TRUCKING LIMITED 076258 MCKEIL MARINE LIMITED 077123 NEWS MARKETING CANADA CORP. 636628 Peake & McInnis Ltd.

643154 624123 611594 650188 649602 647445 073658 076658 649819 650081

PRO FORÊT EXCELLENCE INC. Q1 Labs, Inc. REGAL-BELOIT HOLDINGS LTD. Reinhausen Canada Inc. Shred-it International Inc. Superior Kitchen Designs, Inc. TRUSERV CANADA INC. Tulsa Inc. TUMBLEWIRE INC. WELLINGTON WEST CAPITAL MARKETS INC.

Companies Act

Loi sur les compagnies

Notice of decision to dissolve provincial companies Take notice that the Director under the Companies Act has made a decision to dissolve the following companies pursuant to paragraph 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.

Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compagnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites compagnies.

022317 58 LEGION COURT INC. 000701 ARGOSY PUBLICATIONS INC. 023051 ASSEMBLIES OF THE LORD JESUS CHRIST OF NEW BRUNSWICK INC. 624320 ASSOCIATION DES FAMILLES THÉRIAULT DU NOUVEAUBRUNSWICK INC. 643839 Atlantic Fermenters Association Inc. 605740 BATHURST SUPERIOR CAFETERIAS INC. 024153 BELLEDUNE RIVER CEMETERY INC. 023681 BELLEISLE VALLEY RECREATIONAL ASSOCIATION INC. 002919 CANADIAN FORESTRY ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK, INC. 003274 CENTRAL NEW BRUNSWICK WOODMEN’S MUSEUM INC. 003304 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DIEPPE INC. 003313 CENTRE CULTUREL D’ALLARDVILLE INC. 023117 CLUB DE CURLING TRACADIESHEILA INC. 013318 CLUB RICHELIEU FREDERICTON INC.

636921 Community Homeless Network Inc. / Réseau communautaire des Sans abri. Inc. 025087 COMPASSION SERVICES OF CANADA, INC. 004441 COVENANT REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF NEWCASTLE INC. 600004 DOUGLASTOWN COMMUNITY CHURCH INC. 023891 FUNDY TRAILRIDERS ATV & SNOWMOBILE CLUB INC. 024908 GRACE BAPTIST CHURCH (INDEPENDENT) OF MONCTON, INC. 650175 HAVELOCK HORIZONS INC. 624423 HOPE PARTNERS INTERNATIONAL INC. 600007 Impossible Realities Inc. 008465 INKERMAN RECREATION COUNCIL INC./CONSEIL RECREATIF D’INKERMAN INC. 008714 JACQUET RIVER LIONS CLUB INC. 605759 KENNEBECASIS VALLEY COMMUNITY - CAPACITY CHILDREN INC.

023427 KINETTE CLUB OF THE MIRAMICHI INC. 024364 L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU CENTRE D’EXCELLENCE DU TOURISME DE L’ATLANTIQUE (AE-CETA) LTÉE 643326 LA MAISON DE LA FAMILLE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE INC. 636863 La Solitude de Pré-d’en-Haut Inc. 021803 LEAF TRAILS INC. 022314 LES RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE INC. 022532 Ligne Téléphonique C.A.R.A. Help Line Inc. 022879 METRO HEALTH SERVICES INC. 025580 MIRAMICHI JUNIOR “A” HOCKEY CLUB INC. 609070 New Bandon/Salmon Beach Social Committee Inc. 025582 NEW BRUNSWICK ANTI-POVERTY LEGAL CLINIC INC. 021821 NEW BRUNSWICK LIBRARY TRUSTEES’ ASSOCIATION INC./ L’ASSOCIATION DES COMMISSAIRES DE BIBLIOTHEQUES DU NOUVEAUBRUNSWICK INC.

The Royal Gazette — February 22, 2012 012138 NEW DENMARK HISTORICAL SOCIETY INC. 024906 NEW DENMARK SENIORS’ COMPLEX INC. 600003 Northside Youth Centre Inc. 024716 OPERA NEW BRUNSWICK INC. 024162 PLACE HISTORIQUE DU MADAWASKA INC 600000 Purdy’s Corner Townhouse Association Inc. 023400 RENOUS KNIGHTS CHARITIES INC. 014009 RICHIBUCTO LIONS CLUB INC. 022107 ROTARY CLUB OF BATHURST CHARITY FUND INC.

Gazette royale — 22 février 2012

295 022101 ROTARY CLUB OF GAGETOWN, NEW BRUNSWICK, INC. 018323 ROYAL CANADIAN LEGION MONCTON # 6 014993 SENIOR CITIZENS SERVICES SAINT JOHN INC. 025706 SHEDIAC BAY WATERSHED ASSOCIATION INC./L’Association du bassin versant de la baie de SHEDIAC Inc. 611356 Silicon East Inc. 643713 St. Joseph’s Hospital Auxiliary Inc. 022556 THE CHALEUR GROUND SEARCH AND RESCUE TEAM INC. 617472 THE JOSHUA EVANS’ TRUST INC.

Partnerships and Business Names Registration Act

011864 THE N. B. I. P. CO. EMPLOYEES’ ASSOCIATION INC. 015954 THE TABUSINTAC CLUB, LIMITED 637023 Victoria Park Enhancement Committee 2008 inc. 025715 VICTORIAN ORDER OF NURSES CANADA NEW BRUNSWICK BRANCH INC. 016766 VICTORIAN ORDER OF NURSES, (MONCTON BRANCH), INC. 624535 VICTORY LIGHTHOUSE INC. 016974 WAUKLEHEGAN MANOR INC. 650112 Western Valley Adult Learning Association Inc.

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Partnerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of business names of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said firms and businesses have failed to register certificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act.

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas.

FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Registrar may cancel the registration of the said certificates of partnerships and certificates of business names.

SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom collectif et certificats d’appellations commerciales.

Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif 629575 629886 629781 629176 629208 351048

Barb’s B & B BLACK BOWSER COMICS Fortune Market KC Solid Surface MARK’S STEAM CLEAN Mountain View A.T.V. Outdoor Adventures

629656 628854 348436 629426 629497

RaJe Informatik Rejuvinate Spa RoMar REAL ESTATE MANAGEMENT ScrapAway SHALLAN & SARA MESSAGE IN A BAG 629285 SHELL CANADA ENERGY

350821 SHELL CANADA PRODUCTS/ PRODUITS SHELL CANADA 629818 Staged Designs 629661 TARGET MAGAZINE 338086 TRIPLE F RANCH

____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales 629990 (KCMS) Key Concepts Management Systems 629588 ACADIAN RIM RECYCLING 629736 AFS Leasing 629645 AfterImage New Media 629976 AKELA Canoes 629903 ALBA TOURS 348469 Alliance Flow Products 340870 ALPHAPLEX CUSTOM FABRICATION 629904 ALUMNI HOLIDAYS 353107 AMBER STAINED GLASS

629345 610529 629784 629734 629706 629662 629989 629468

Atlantic Mobility Products Atlantic Towing / Kent Line Operations ATTKINS SOUL Auto Sales Unlimited Auto Stream Avenue Appliances AVENUE MOTORSPORTS Bathurst Mortgage Center/Centre Hypothécaire Bathurst 629805 Bennett Occupational Therapy 629635 Bernie’s Auto Cure 629601 Blue Backyard Consulting

629571 629512 629951 628857 629612 335311 629682 629658 628288 630000 629691 629839

BMC GROUP Brad LeBlanc Enterprises Brafasco BRAKEWHEEL PRODUCTS Bravurin Technologies BRUNSWICK LOAN ACCEPTANCE C.P. COMPUTER DOCTOR Cabinet Kevin J. Haché Cafe-Bistro Mon Ami Canada St. Variety Canadian Green Products Capital ADvice Advertising

The Royal Gazette — February 22, 2012 348539 CAPITAL PEST CONTROL 629905 CARRIES TRAVEL INTERNATIONAL 629992 CHÂTEAU ROYAL: CENTRE DE VILLÉGIATURE FAMILIAL 629993 CHÂTEAU ROYALE: A FAMILY RESORT 330358 CHINA COAST 350863 Claremont Communications 351049 Clinique de Massothérapie de Shédiac Shediac Massage Therapy Clinic 348530 Cobalt60 Design & Graphics 629549 Coiffure Esthetique Sylvie Drouin 629578 COLLETTE CONSULTANT 629970 COMMUNICATIONS COURTCIRCUIT - SHORT CIRCUIT COMMUNICATIONS 629506 Confident Solutions 629586 COOPER FRIDAY’S 629959 COUNTRY ROADS CIDER C0. 353143 COURTENAY INSURANCE AGENCY 629906 CRONOS TRAVELPLAN 629907 CRUISEESCAPES 629769 Dabest IT Consulting 348496 DAVE BALDWIN AUTO SALES 350993 DEBI’S HAIRDRESSING 1409 629752 Decorating Dimensions 350907 Decorative Treasures 629895 Déja vu Second Hand Store 350894 DÉJÀ-VU SIGNS ETC. 348590 DENTS BE GONE 348531 DIANE TERRY, MASSAGE THERAPY 629611 DLA Sales & Marketing 629463 DNR Jewellery Exchange 629657 DOMAINE DE LA VALLÉE DE LACBAKER 629458 DPT SECURITY 629550 East Coast Automotive Warehousing 348429 Edward Hanselpacker Auto Repair 629852 Elbow Grease Welding 337839 EMPIRE ELECTRIC 629812 Ethnic Rainbows Native Cast 319479 EVERY THING WE TOUCH TURNS TO SOLD 629825 Evolution Stone Works 353231 FARRELL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 629871 FIRE READY EXTINGUISHER SALES & SERVICE 348395 FOREMOST INSURANCE 350881 FROG’S PAD 629459 FTI Group 629633 Fundy Alternative Power 627708 Garderie Chez Catherine 629543 Gladstone Alpacas 350663 Gleason Arms 629742 GORDIE’S PUB 629730 Gould’s RenoScaping 629949 Grafton Utility Supply 629953 Grafton Utility Supply (Western) 629950 Grafton West 629584 GULLISON’S COURIER SERVICE 629465 Haddad Marketing 629718 Happy and Healthy Products for Mind, Body and Soul 316673 HARRIS REBAR 629610 Harvest Moon Soap 629941 HD Supply 629942 HD Supply Canada 629946 HD Supply Electrical 629943 HD Supply Facilities Maintenance 629952 HD Supply Fasteners & Tools 629948 HD Supply Utilities 629449 Hoffmann Design 629793 HOUSE OF TUDOR 350990 HUBCAP COMEDY FESTIVAL DE L’HUMOUR

296 629749 629748 629527 629675 629764 629614 629704 629668 629597 629833 353261 629789 629616 348405 629595 629644 350879 629790 629686 629674 629690 350914 629834 629846 629735 629900 629689 629826 629775 629945 629596 629478 629977 629581 629338 629340 629339 629519 629751 629698 350903 346046 629750 629680 629897 629795 353280 629688 629995 629667 629797 629104 629490 629712 350935 629498 629891 629554 629910 629911 629912 629913 629914 629916 629915 629917 629880 314566 314567

HURON DUST CONTROL HURON MATS RENTALS IMAGINiT Technologies Independent Ironworks INDOR MFG. Inner Beauty Esthetics Innovative Interpretations Hospitality Consulting InsTint Window Tinting J.R. LIQUIDATORS JAGUAR CREDIT CANADA LEASING JC Linder Ventures Jeff Bonnar & Son Renovators JFR Communications Julie’s Beau-T Stop Kelly’s Travel And Tours KGM Roofing and Home Improvement KILLAMS WELDING & MACHINING Knotty Girl Fibre Arts KOVACK TREE SERVICES KUTZ FOR MEN KYLE BROWN MEMORIAL FUND L.M.A.C. GOBI LAND ROVER FINANCIAL SERVICES LEASING Laundromat Espresso Bar Lavender Lane Cottage LEELAND TRUCK & EQUIPMENT SALES Lemon Tree Gifts and Crafts Liberty Alliance LITEMOR Litemor Distributors Little Acorns LITTLE JOHN’S VARIETY LJW Choice Consulting Local Moving & Storage Location Crédit Jaguar Canada Location Crédit Mazda Canada Location Services financiers Land Rover Lynch’s Accounting Service Lynne Breen Photography M. P. Creations MAJESTIC JUICES Maliseet Smoke Shop MARCHE INKERMAN ENRG. Marilyn Bustard, Custom Sewing MARINER’S REACH Maritime Precision Industries MARLOG CONSULTING MASCARET MEDIA Master CopyCats Mathis Consultants McDonough Bros. Landscaping Melda’s Art Shop Melvin’s Cafeteria Mike Gould Enterprises MIRAMICHI UNIQUE UNIFORMS MONEY IN YOUR POCKET DEPOT Musée de la Bière My Super Vacations MYALBATOURS MYENCORE CRUISES MYHOLIDAY HOUSE MYNETWORK MYSUNQUEST MYTOURS MAISON MYTRAVEL CRONOS TRAVELPLAN NETWORK INTERNATIONAL AIRFARES NEW WAY MOVING AND STORAGE NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF ANGLERS AND HUNTERS NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF HUNTERS

Gazette royale — 22 février 2012 314568 NEW BRUNSWICK FISH AND GAME ASSOCIATION 629994 New England Pizza Company 629460 NEWAY MOVING & STORAGE 629779 NIGHT SHIFT JANITORIAL 350912 Northumberland Funeral Home 351034 Old English Motorcycles 352785 Paige One Enterprises 628820 Pauley & Sons Sales Agency 623123 Pêcheries F.N. 353200 PENTARUS GRAPHICS 353279 PFC CONSULTING 629771 Phillips Security Personnel 348127 PL Digital Informatique & Satellite Enr. 629660 PORCUPINE KING 629935 POTATO INTERNATIONAL 353197 Pro-Tect Installers 629515 R & R Auto Clinic 353194 R.D.C. SPORT 629504 Randy’s Tickle Trunk 629975 RE/MAX GROUP FOUR REALTY 629613 Red Pines Art Studio 629711 Red Wave Solutions 629598 REMEMBER MONCTON OU VENIR 629858 RENT-A-MAN 350938 RICHARD BOOKKEEPING 350943 Richard Marine Sales and Service 629968 RIVER VALLEY FIRE CONSULTING 629753 Rogersville Cafe 348582 SAMUEL DOW EXPLOSIVE ORDANANCE DISPOSAL CONSULTANT 629997 Saulnier Maintenance 629679 SCHLUMBERGER ARTIFICIAL LIFT 629482 SCHLUMBERGER COMPLETIONS 629479 SCHLUMBERGER TESTING 629813 Sensabella Esthetics & Nail Studio 629967 Sevans Small Business Consulting 629714 Shear Clothing 350964 SHIRETOWN STORAGE 629901 SILI-CON LOGISTICS 629919 SILVER FERN HOLIDAYS 312336 SMITTY’S FAMILY RESTAURANT 629604 Sneek A Peek Gifts 629998 Snowbird Financial Services 351021 Soudure Gravel & Fils Enr. 629815 Steel In Time 629485 Stewart Heavy Equipment Contracting & Rentals 629881 Style & Grace Pet Salon 338034 SUCO BUSINESS SERVICES 353252 Team Air Express 353250 Team Customs Brokerage 353251 Team Ocean Services 353253 Team Worldwide 629655 The Celestrial Soul Connection 629579 The Colour Center 629850 THE GOOD GUYS BREW SHOPPE 629632 The Greens Condominium 629944 The Home Depot Supply 629609 The Mattress Medic 629947 The Primitive Cellar 312248 THE SONY STORE 629924 THN EXPLORATIONS 327956 TOUCH OF CLASS SERVICES 629824 TRACY STARR 629888 Transitions Co-Active Life Coaching 629802 Trophy Safaris Int’l New Brunswick 629547 U-Pedal Boats 629965 Valley Restaurant 629777 Vue à vol d’aigle 350931 Wavetech Business Supplies 629637 Whippowill Consulting & Sales 629844 WORLD WINE AND FOOD EXPO 629467 WWWA Wholesale

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

297

Business Corporations Act

Loi sur les corporations commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Registered Office Bureau enregistré

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

661818 NB Ltd.

New Line

661818

2012

01

26

661821 N.B. LTD.

Saint John

661821

2012

01

26

Fine Art Collection Holdings Limited

Saint John

661830

2012

01

26

661831 N.B. Inc.

Oak Bay

661831

2012

01

27

Jean Léger & Son Contracting Inc.

McKees Mills

661832

2012

01

27

Bound Communications Inc.

Lower Woodstock

661833

2012

01

27

661836 NB LTD. 661836 NB LTEE

Perth Andover

661836

2012

01

27

Maritime Daytripping Inc.

Fredericton

661839

2012

01

27

MEGA CHAGA LTD.

Riverview

661840

2012

01

27

661841 NB LTD.

Richmond Corner

661841

2012

01

27

David Long Holdings Inc.

Rothesay

661842

2012

01

27

G.P. APARTMENTS INC.

Saint-Léonard

661843

2012

01

27

661845 N.-B. INC.

Caraquet

661845

2012

01

27

661846 NB Ltd.

Saint John

661846

2012

01

27

CAMERA CREW MEDIA PRODUCTION CORP.

Moncton

661867

2012

01

27

661868 N.B. LTD.

Grand-Sault / Grand Falls

661868

2012

01

28

Timoe Express Inc.

Bouctouche

661869

2012

01

29

ElectroCore Canada, Inc.

Saint John

661870

2012

01

30

661871 N.-B. CORP.

Moncton

661871

2012

01

30

Northern Highlights Hair & Body Salon Ltd.

Fredericton

661872

2012

01

30

KSK Holdings Inc.

Moncton

661874

2012

01

30

Dent Pro Hail Repair Inc.

Riverview

661880

2012

01

30

ROYAL ATLANTIC OYSTER INC.

Saint-Louis

661881

2012

01

30

Saint John Early Childhood Centre Ltd.

Saint John

661883

2012

01

30

TOBIQUE FARMS OPERATING (2012) LIMITED

DSL de / LSD of Drummond

661889

2012

01

30

Fortin Construction (2012) Inc.

Grand-Barachois

661891

2012

01

30

EXHALE YOGA BOUTIQUE INC.

Campbellton

661892

2012

01

30

MSP Work Solutions Inc. / Solutions au travail MSP Inc.

Moncton

661893

2012

01

30

MDS IGLASS INC.

Moncton

661894

2012

01

30

K&W ENTERPRISES LTD.

Apohaqui

661903

2012

01

31

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

298

C. Scott Holdings Ltd.

Saint John

661908

2012

01

31

661913 NB Inc.

Moncton

661913

2012

01

31

TEC Encryption Technology Ltd.

Shediac

661918

2012

01

31

Three Talons Investigations Ltd.

Saint John

661921

2012

01

31

FREDDIE’S PIZZA LTD.

Moncton

661923

2012

01

31

Sugarloaf Estates Inc.

Moncton

661924

2012

01

31

Ryan Oak Estates Inc.

Moncton

661927

2012

02

01

661928 N.B. INC.

Riverview

661928

2012

02

01

DR. BRETT TREMBLE PROFESSIONAL CORPORATION

Moncton

661929

2012

02

01

Coast Tire (Summerside) Ltd.

Saint John

661939

2012

02

01

Brian Morin Construction Inc.

Edmundston

661941

2012

02

01

Carter’s Cranberries Inc.

Central Blissville

661942

2012

02

01

Chantal’s Steakhouse Inc.

Saint-Joseph

661950

2012

02

02

Burke & Theriault Investments Ltd.

Fredericton

661955

2012

02

02

TONA Holdings Ltd.

Island View

661956

2012

02

02

MP Investments Corp.

Island View

661957

2012

02

02

661958 N.B. Ltd.

New Denmark

661958

2012

02

02

Gold Bar Development & Consulting Inc.

Shediac

661965

2012

02

02

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à :

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

Previous Jurisdiction Compétence antérieure

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

661047 N.B. Inc.

Saint John

Canada

661047

2012 01

31

661048 N.B. Inc.

Saint John

Canada

661048

2012 01

31

661046 N.B. Inc.

Saint John

Canada

661808

2012 01

31

GREEN HAVEN MOBILE HOMES LIMITED

Saint John

Ontario

661811

2012 01

31

COWAN PLACE LIMITED

Saint John

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

661812

2012 01

31

VOGUE HOLDINGS INC.

Saint John

Île-du-Prince-Édouard / 661930 Prince Edward Island

2012 01

31

_____________________________________________________

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

299

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à :

Name / Raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

GUIDOU ELECTRIC LTD.

007580

2012 01

31

J. L. SIMMS (’74) LTD.

015203

2012 01

30

CAJO MARTEL TRANSPORT LIMITEE

020201

2012 01

27

CLEARWATER WELL DRILLING (1983) LTD.

031695

2012 01

31

WALCOTT MACHINING AND FABRICATION LTD.

059792

2012 01

31

Fermes Semences Desjardins Seed Farms Ltd./Ltée

512472

2012 01

27

LITECO INC.

513882

2012 01

31

HARD ROCK DRILLING LTD.

606390

2012 01

27

I. GÉRALD LÉVESQUE CORPORATION PROFESSIONNELLE / I. GÉRALD LÉVESQUE PROFESSIONAL CORPORATION

608311

2012 01

31

635116 N.B. LTD.

635116

2012 01

31

JAKAS Holdings Inc.

635117

2012 01

31

SwiftRadius Inc.

635872

2012 01

31

BREWCO PLANNING INC.

642006

2012 02

01

661378 N.B. Ltd.

661378

2012 02

01

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à :

Name / Raison sociale

Previous name Ancienne raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

QPS Canada Inc.

Interactive Visualization Systems, Inc.

608306

2012 01

26

608667 NB Inc.

EAST SIDE SPORTS INC.

608667

2012 01

26

CHARLES STREET FINANCIAL INC.

Son Communications Inc.

617213

2012 01

31

Productions Siallam Inc.

644931 N.-B. Ltée

644931

2012 01

31

Phytoplankton Biotech Inc.

Sackville Jam Shack Ltd.

653307

2012 01

31

654744 N.-B. INC.

654744 N.-B. INC.

654744

2012 01

31

Tri-Star Antimony Canada Inc.

656952 N.B. Inc.

656952

2012 01

27

658785 N.B. Inc.

Maritime Fastening Systems (2011) Inc.

658785

2012 01

30

X & O HOLDINGS LTD.

659780 NB INC.

659780

2012 01

31

Westmorland Animal Hospital Inc.

660908 NB Inc.

660908

2012 01

25

_____________________________________________________

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

300

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à :

Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes

Registered Office Bureau enregistré

Reference Number Numéro de référence

L.M.D. Holdings Ltd.

L.M.D. HOLDINGS LTD. 630921 N.B. Ltd.

Moncton

661715

2012 01

31

Stewie’s Lobsters Ltd.

CHAOS FISHERIES LTD. STEWIE’S LOBSTERS LTD.

Alma

661779

2012 01

31

660551 NB LTD.

055720 N.B. LTD. 660551 NB LTD.

Bath

661855

2012 02

01

LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.

CORLAND CONSTRUCTION INC. LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.

Dieppe

661859

2012 02

01

Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD A. BOLDUC, M.D., C.S.P.Q., Dermatolgue Inc. F.R.C.P.(C),C.P. Inc. Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD Dermatologue Inc.

Moncton

661877

2012 02

01

628377 NB INC.

628377 NB INC. 658580 NB LTD.

Fredericton

661905

2012 02

01

Liteco Inc.

SJK HOLDINGS LTD. LITECO INC. R.G.M. INVESTMENTS (2006) INC.

Fredericton

661914

2012 02

01

049046 N.B. Ltd.

049046 N.B. LTD. CHIGNECTO ENTERPRISES LIMITED LONAMY INC.

Upper Coverdale

661916

2012 02

01

Belmar Investments Limited

Mejora Holdings Limited Belmar Investments Limited

Woodstock

661945

2012 02

01

Date Year Month Day année mois jour

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à :

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

GARAGE ST. PIERRE LTEE

Kedgwick

006928

2012

01

19

NORTH SHORE ALARMS-HUDON’S SECURITY SERVICES CO. LTD.

Bathurst

032714

2012

01

30

Cebacob Holdings Ltd.

Bocabec

033407

2012

01

26

CHARLES E. WILLIAMS & COMPANY LTD

Grand Bay-Westfield

047441

2012

01

20

ENTREPRISE S.K. (1993) LTEE

Kedgwick

053507

2012

01

19

SLEDS & TREADS LTD.

Sussex

500742

2012

01

27

JOE’S WOODWORKING LTD.

Fredericton

504033

2012

01

31

MOUNT MISERY HOLDINGS INC.

Kingston

506518

2012

01

26

Anacomp Canada Inc.

Saint John

604923

2012

01

25

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

301

MHR HOLDING INC.

Moncton

606039

2012

01

30

The Davis & Lee Financial Planning Centre Ltd.

Rothesay

610535

2012

01

10

Kindred Sound Productions Inc

Saint John

610814

2012

01

25

JD Vending Inc.

Dieppe

622448

2012

01

26

Executive Auto Imports Ltd.

Fredericton

633720

2012

01

26

Accurate Tax & Accounting Inc.

Saint John

636674

2012

01

19

Lemon Chiffon Ventures Limited

Saint John

638369

2012

01

19

Cogwheel Properties Limited

Saint John

643063

2012

01

25

Charlie’s Trucking Inc.

Saint-Charles

644139

2012

01

27

Braeside Solar Park 2 GP Inc.

Saint John

653731

2012

01

23

MSD E-Commerce Solutions Ltd.

Belleville

655032

2012

01

19

Cusack Real Property Consulting Ltd.

Saint John

655248

2012

01

18

Canatara Solar 1 GP Inc.

Saint John

657785

2012

01

23

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, notice of the discharge of a receiver or a receivermanager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les sociétés suivantes a été reçu :

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

Receiver or Receiver-Manager Séquestre ou séquestre-gérant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Deer Island Salmon Ltd.

Lords Cove

Ernst & Young Inc.

053503

2012

02

02

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

Name / Raison sociale

Scandinavian Tobacco Group Canada Inc./ Groupe Tabac Scandinave Canada Inc.

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de cessation a été émis à :

Jurisdiction of Continuance Compétence de prorogation

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Québec / Quebec

661314

2012 01

16

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à :

Name / Raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

O’BRIEN & LANDRY LIMITED

012504

2012 01

26

J.M. & C.W. HOPE GRANT LTD.

038664

2012 01

26

DUNCAN HOLDINGS LTD.

057091

2012 01

26

T & L Electrical Ltd.

615744

2012 01

26

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

302

WENDY SERGEANT GENERAL CLEANING LTD.

620737

2012 01

27

Wards Creek Holdings Ltd.

634847

2012 01

26

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Jurisdiction Compétence

Agent and Address Représentant et adresse

VANGUARD INVESTMENTS CANADA INC. PLACEMENTS VANGUARD CANADA INC.

Canada

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661605

2012 01

17

Specialty Risk Underwriters Inc.

Canada

David Bruce Cannon Irishtown

661616

2012 01

17

Product Remanufacturing Centers Canada, Canada Limited Centres de Remise à Neuf de Produits Canada, Limitée

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661626

2012 01

18

P.S. Atlantic Limited

Struan Smith Moncton

661666

2012 01

19

Ontario XEROX FINANCIAL SERVICES CANADA LTD./SERVICES FINANCIERS XEROX CANADA LTEE.

William T. Walker Fredericton

661705

2012 01

20

Affordable Plumbing & Mechanical Inc.

Ontario

Alison J. Harvey Haut-Sheila

661750

2012 01

24

ASPHALTE BAS-ST-LAURENT INC.

Canada

Daniel Bélanger Grand-Sault / Grand Falls

661751

2012 01

24

Bouclair Inc.

Québec / Quebec

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661776

2012 01

25

Wingenback Inc.

Alberta

Sheryl D. Tabor Sussex

661777

2012 01

25

Bruns-Pak Worldwide, Inc.

New Jersey

Steven D. Christie Fredericton

661792

2012 01

25

FRONTLINE RAILCAR REPAIR LTD.

Saskatchewan

John B. Malone Sussex

661853

2012 01

27

Provident Agency, Inc.

Canada

Craig A. Sampson Moncton

661854

2012 01

27

ASSURANCES NORMAN MCCANN INC.

Québec / Quebec

Norman McCann Caraquet

661873

2012 01

30

Tundra Consulting Inc.

Nunavut

R. Gary Faloon Saint John

661885

2012 01

30

Name / Raison sociale

Terre-Neuve et Labrador/ Newfoundland and Labrador

_____________________________________________________

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

303

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à :

Previous name Ancienne raison sociale

Name / Raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

AZGA Insurance Agency Canada Ltd.

WORLD ACCESS INSURANCE BROKERS LTD.

600874

2012 01

27

326551 Canada Inc.

Bodkin Leasing Corporation

612286

2012 01

18

3267911 Canada Inc.

Bodkin Capital Corporation

612287

2012 01

18

IKON Office Solutions ULC

IKON OFFICE SOLUTIONS, INC./ IKON SOLUTIONS DE BUREAU, INC.

615949

2012 01

23

AZGA Service Canada Inc.

World Access Canada Inc.

639363

2012 01

27

Dynamitage Castonguay ltée / Castonguay Blasting Ltd.

DNX Castonguay Inc.

648699

2012 01

23

Atos IT Solutions and Services Inc./ Atos Solutions et services en TI inc.

Siemens IT Solutions and Services Inc./ Siemens Solutions et services en TI Inc.

651618

2012 01

31

Skyline Wealth Management Inc.

Skyline Asset Management Inc.

653234

2012 01

24

FGL Sports Ltd. FGL Sports Ltee

FGL AcquisitionCo Limited

661807

2012 01

26

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations:

Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Représentant et adresse

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

EXTENDICARE (CANADA) INC. EXTENDICARE (CANADA) INC.

Steven Christie Fredericton

661088

2012

01

19

Siemens Canada Limited/ Siemens Canada Limited

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC LTD. SIEMENS DIAGNOSTICS EN SOINS DE SANTÉ LTÉE SIEMENS CANADA LIMITED / SIEMENS CANADA LTÉE

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661684

2012

01

20

NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Stewart McKelvey NEBS PAYROLL SERVICE Corporate Services (NB) Inc. LIMITED Saint John NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

661685

2012

01

20

KODAK CANADA INC.

KODAK CANADA INC.

George L. Cooper Moncton

661701

2012

01

20

Cliffs Chromite Ontario Inc.

Cliffs Chromite Ontario Inc.

George L. Cooper Moncton

661702

2012

01

20

MGA PARTNERS INC.

Blonde & Little Financial Services Ltd Terry Fitzgerald Fredericton

661712

2012

01

20

Ricoh Canada Inc.

IKON Office Solutions ULC Ricoh Canada Inc.

661741

2012

01

23

Bernard F. Miller Moncton

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

304

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Human Resource Capital Group Inc. Stewart McKelvey Groupe Capital de Ressource Humaine Corporate Services (NB) Inc. Saint John Inc. Randstad Intérim Inc./Randstad Interim Inc.

661744

2012

01

24

JIM PEPLINSKI LEASING INC.

JIM PEPLINSKI’S AUTO LEASING Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. LTD. Saint John HUMBERVIEW MOTORS INCORPORATED

661771

2012

01

25

Homewood Human Solutions Canada Inc.

Homewood Human Solutions Canada Stewart McKelvey Inc. Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661775

2012

01

25

The Forzani Group Ltd.

SPORTS EXPERTS 2000 INC. THE FORZANI GROUP LTD. Sport-Chek International 2000 Ltd.

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661806

2012

01

26

FGL AcquisitionCo Limited

The Forzani Group Ltd.

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661807

2012

01

26

LAFARGE CANADA INC.

LAFARGE CANADA INC.

Alex Kennedy Moncton

661856

2012

01

27

Element Financial Corporation

ELEMENT FINANCIAL CORPORATION

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661861

2012

01

27

Hazmasters Inc.

Hazmasters Inc.

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661862

2012

01

27

Companies Act

Loi sur les compagnies

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes ont été émises à :

Name / Raison sociale

Head Office Siège social

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

LES BRAYONS MASQUÉS INC.

Edmundston

661784

2012 01

25

HAITI VILLAGE HEALTH INC.

Miramichi

661847

2012 01

27

CHILD CARE OWNERS’ & OPERATORS OF SOUTHERN NEW BRUNSWICK INC.

Saint John

661906

2012 01

31

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, supplementary letters patent have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes supplémentaires ont été émises à :

Name / Raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

MULTICULTURAL ASSOCIATION OF FREDERICTON INC.

011467

2012

_____________________________________________________

01

27

The Royal Gazette — February 22, 2012

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

Gazette royale — 22 février 2012

305

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

Name / Raison sociale

MEMRAMCOOK VOLUNTEER FIREMEN’S ASSOC. INC. L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE MEMRAMCOOK INC.

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

010863

2012 01

27

Partnerships and Business Names Registration Act

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Certificate Enregistreur du certificat

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

NORTH SHORE CINEMA

633970 N.B. Limited

Campbellton

661172

2012 01

26

Tradewinds Truck Service

Scoudouc Truck Service Inc.

Shediac

661492

2012 01

23

Bay of Fundy Adventures

630227 N.B. INC.

Rothesay

661613

2012 01

17

Kane Construction

630227 N.B. INC.

Rothesay

661614

2012 01

17

GOLD BUYERS NEW BRUNSWICK Mark Rzepka

Saint John

661625

2012 01

18

Fairvale Physiotherapy Clinic

PT Health NB Professional Corporation

Rothesay

661639

2012 01

18

River Valley Ventilation & Heating

Luke Dukeshire

Northampton

661662

2012 01

27

Stever-Ryu Jujutsu

Nathan Stever

Big River

661664

2012 01

19

SWIT SWOO SERVICES

Harvey A. Hillis

Florenceville-Bristol

661669

2012 02

01

Agence basKASTing Agency

Julie Basque

Tracadie-Sheila

661671

2012 01

31

Buanderie Dieppe Laundry

659298 NB INC.

Dieppe

661697

2012 01

20

TARGET

TARGET CANADA CO.

Saint John

661717

2012 01

23

TARGET CANADA

TARGET CANADA CO.

Saint John

661718

2012 01

23

MAISONS LEVESQUE

GÉRANCE DE PROJET RÉSIDENTIEL

Dieppe

661724

2012 01

23

KANE HOMES

630227 N.B. INC.

Rothesay

661729

2012 01

23

Salon Milady

Denise Lanteigne

Caraquet

661730

2012 01

23

The General Store St. Andrews

659761 N.B. INC.

Saint Andrews

661734

2012 01

27

Kevin Dinsmore Painting

Kevin Dinsmore

Pomeroy Ridge

661739

2012 01

23

VETEMENTS O BON PRIX ENR.

CHEZ ROBICHAUD LTEE

Shippagan

661752

2012 01

24

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

306

KV VINEYARD

KENNEBECASIS VALLEY VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP INC.

Quispamsis

661763

2012 01

24

TEAM BESLER

MGI SECURITIES INC.

Saint John

661778

2012 01

25

Moncton Kiwanis Basketball Association

MONCTON MINOR BASKETBALL ASSOCIATION, Inc.

Moncton

661780

2012 01

25

New Brunswick Northern Railway Company

NEW BRUNSWICK SOUTHERN Saint John RAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAUBRUNSWICK LIMITEE

661785

2012 01

25

NB Northern

NEW BRUNSWICK SOUTHERN Saint John RAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAUBRUNSWICK LIMITEE

661787

2012 01

25

Raduga Market

Gelena Devedjinejad

Moncton

661788

2012 01

25

Modern Hüs

Jon-Matthew O’Hara

Moncton

661815

2012 01

26

KING PERFORMANCE

Gordon King

Fredericton

661816

2012 01

26

DUKE CREATIVE COLLECTIVE

Elizabeth Richardson

Saint John

661825

2012 01

26

SAILBLOG.NET

Michael Taylor

Saint John

661834

2012 01

27

Centre de conditionnement ÉducACTION (Edmundston)

Mike Couturier

Edmundston

661837

2012 01

27

FACE-IT GENEVIÈVE

Geneviève Albert

Moncton

661838

2012 01

27

Hubert Williston Renovations and Construction

Hubert Williston

Napan

661844

2012 01

27

MCGUIRE REHAB RENOS

MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.

Saint John

661848

2012 01

27

MCGUIRE’S TRINKETS & TREASURES

MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.

Saint John

661849

2012 01

27

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

AZGA Insurance Agency Canada Ltd.

Saint John

661857

2012 01

27

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

AZGA Service Canada Inc.

Saint John

661858

2012 01

27

SNACKMAN VENDING SERVICES Chris Morrison

Moncton

661865

2012 01

27

Sussex Ventilation & Heating

Gordon Keddy

Sussex

661875

2012 01

30

Yellowline Vending

Tim Rose

Moncton

661878

2012 01

30

VÂN’s NAILS

BichVan Tuthi

Bathurst

661879

2012 01

30

Progress at Home Physiotherapy

Natalie Ann Brand Russell

Quispamsis

661888

2012 01

30

RRNJ Style Sales

Roxanne Maillet

Moncton

661890

2012 01

30

Chris Parks Trucking

Chris Parks

Moncton

661895

2012 01

31

JOE’S WOODWORKING

Joe Pitre

Fredericton

661900

2012 01

31

Sunset Realty Group

David Boucher

Dieppe

661901

2012 01

31

R. Nason Renovations

Rick Nason

Geary

661904

2012 01

31

ADRIAN FORGIE BUILDER CONTRACTOR

Adrian Forgie

Rothesay

661910

2012 01

31

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

307

JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS Dwight Cummings SOLUTIONS

Saint John

661911

2012 01

31

MR HANDYMAN BY SERGE

Serge Ethier

Saint John

661912

2012 01

31

LAURA COMEAU ART

Laura Lea Wergin Comeau

Derby

661917

2012 01

31

Barachois Vehicle Import Personal Auto Sales

John MacNeill

Grand-Barachois

661919

2012 01

31

S. Macphee Auto Salvage

Scott Macphee

Petitcodiac

661920

2012 01

31

FK MotoTech

Francis Séguin

Oromocto

661922

2012 01

31

NINE-DOT MARKETING

Christopher Bastarache

Moncton

661925

2012 02

01

Sweetstix Treats

Adrianna Stevens

Moncton

661926

2012 02

01

NLB Nuclear Process Services

Normand L. Boucher, P.Eng

Saint John

661935

2012 02

01

Phil’s Automation Industrial Control Systems

Philip Kilpatrick

Picadilly

661938

2012 02

01

BDLAW

Brent A. Dickinson

Woodstock

661940

2012 02

01

Exclusive Events

Jennifer Mae Rose

Oromocto

661943

2012 02

01

Natures Pet Spa

Jennifer Stenzler

Dieppe

661966

2012 02

02

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales In relation to the certificate of business name registered on January 18, 2012 under the Act, under the name of “Fundy Flair For Hair”, being file #661648, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the name of the person in section 3 of form 5 be corrected to read as follows “Tammie Wyttner”. Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 18 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « Fundy Flair For Hair », dont le numéro d’appellation commerciale est 661648, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que le nom de la personne indiquée à la section 3 du formulaire 5 soit corrigé pour qu’il se lise comme suit : « Tammie Wyttner ». _____________________________________________________ In relation to the certificate of business name registered on January 31, 2012 under the Act, under the name of “JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS”, being file #661911, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name be corrected to read as follows: “JPS SIGNS AND IDENTIFICATION SOLUTIONS”. Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 31 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS », dont le numéro d’appellation commerciale est 661911, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que l’appellation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « JPS SIGNS AND IDENTIFICATION SOLUTIONS ». _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Name / Raison sociale

Registrant of Certificate Enregistreur du certificat

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

VERNON BISHOP TOWING

Vernon Bishop

Chipman

321834

2012 01

26

LITECO

Liteco Inc.

Fredericton

323853

2012 02

01

LA ROMA MOTEL ENRG.

058429 N.B. INC.

Saint-Basile

335005

2012 01

26

CNC GLOBAL SEARCH

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

346054

2012 01

24

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

308

CNC GLOBAL CONSULTING

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

346055

2012 01

24

B.A.S.A. RÉPARATIONS & SERVICES

Frederic Savoie

Balmoral

350623

2012 01

30

McKINNON EXCAV.

Mark A. McKinnon

Quispamsis

350784

2012 01

26

LITETEC

Liteco Inc.

Fredericton

351058

2012 02

01

CCS - Complete Computer Service

Frank David MacNeil

New Maryland

353277

2012 01

31

WESTFIELD BEACH ENTERPRISES

Avril Wood-Toner

Grand Bay-Westfield

353304

2012 01

27

The DFS Group

NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Saint John

603935

2012 01

20

POWER DAWG

Liteco Inc.

Fredericton

605858

2012 02

01

SPHERION

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

615659

2012 01

24

Altron Color Imaging

Kevin Frenette

Moncton

628922

2012 01

28

CLINIQUE TENDANCE SANTÉ NATHALIE

Nathalie Noel-Doiron Hazel McMullin

Shippagan

629048

2012 01

26

Le Bon Sang

Denise Gallant

Bouctouche

629225

2012 01

28

Countertop Creations

COUNTERTOPS PLUS LTD.

Moncton

629261

2012 01

24

Blaney Cycle Supply

Barry Blaney

Nortondale

629387

2012 01

26

John Maunder Insurance

Capital Insurance Services Ltd.

Fredericton

630849

2012 01

25

DFS Business Forms

NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE

Saint John

635532

2012 01

20

TODAYS STAFFING

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

636207

2012 01

24

Sapphire Global Services

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

643769

2012 01

24

Silver Group Purchasing

EXTENDICARE (CANADA) INC.

Fredericton

650621

2012 01

19

CANADA’S CAR MART

OLeary Buick GMC (Saint John Ltd.)

Saint John

651033

2012 01

24

Randstad Technologies

Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.

Saint John

658060

2012 01

24

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré : Address / Adresse

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

FAIRVALE PHYSIOTHERAPY CLINIC

Rothesay

335391

2012

01

18

JIM PEPLINSKI’S LEASEMASTER NATIONAL

Saint John

349576

2012

01

25

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

309

Jean Léger & Son Contracting

McKees Mills

607999

2012

01

27

LAID BACK PUB

Grand-Sault / Grand Falls

608391

2012

02

01

Wendy Sergeant General Cleaning

Bathurst

610451

2012

01

27

FREDDIE’S PIZZA

Moncton

618158

2012

01

31

DOMAINE DU RUISSEAU

Dieppe

636511

2012

01

31

Mondial Assistance

Saint John

638804

2012

01

27

Mondial Assistance

Saint John

639364

2012

01

27

MSP Work Solutions / Solutions au travail MSP

Dieppe

654282

2012

01

30

Tradewinds Truck Service

Shediac

658443

2012

01

23

Pet Grooming by Jennifer

Dieppe

658890

2012

02

02

Xylem Residential & Commercial Water

Saint John

661457

2012

01

31

Xylem Water Solutions

Saint John

661458

2012

01

31

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for service has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

Agent and Address / Représentant et adresse

Name / Raison sociale

ROBERT BURY & COMPANY (CANADA)

Don Poley Moncton

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

628641

2012

01

24

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered:

Name / Raison sociale

Partners / Membres

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

HIGHLITE HAIR SALON

Kevin Russell William Russell

Miramichi

661540

2012

01

27

Hilton Spring Farm

Ruby Spencer Brian Spencer

Parker Ridge

661617

2012

01

17

Frufrus “Asian skin care and beauty products”

Jerome Janson Ong Djoana Marie Wasson

Fredericton

661672

2012

01

19

Rowan McGrath Lawyers

Donald Rowan Law Professional Corporation Elizabeth Mary McGrath

Fredericton

661686

2012

01

20

HARBOUR CENTRE

John Lawson Don Sterritt

Saint John

661727

2012

01

23

KALIE’S BUTTERFLIES

Marie Ann Harrison Jena Lynn Beauchamp

Gagetown

661764

2012

01

24

_____________________________________________________

The Royal Gazette — February 22, 2012 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of firm name has been registered:

Name / Raison sociale

Soucy Richard

Gazette royale — 22 février 2012

310

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement de raison sociale a été enregistré :

Previous Name Ancienne raison sociale

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Soucy Richard Godbout Wallace

Dieppe

625392

2012

02

01

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered:

Name / Raison sociale

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Partners / Membres

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Soucy Richard

Pierre S. Soucy Marc-André Richard

Dieppe

625392

2012

02

01

Resto Ma-Gi-Co

Gisele Boudreau Marie-May Boudreau

Shediac

629047

2012

01

24

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Retiring Partners Associés sortants

Incoming Partners Nouveaux associés

Spacek & Associates Chartered Accountants

Bruce Lunergan Professional Corporation

Nick Norrad Professional Corporation

345806

2011

12

28

Shell Canada Upstream

Duvernay Oil Corp.

Shell Canada Limited

641663

2012

01

25

Name / Raison sociale

Limited Partnership Act

Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par :

Name / Raison sociale

Matrix 2012 - I National and Quebec Resource Flow Through LP

Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick

Jurisdiction Compétence

Saint John

Ontario

Agent and Address Représentant et adresse

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

661627

2012

01

18

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

311

HETTICH CANADA LIMITED PARTNERSHIP

Moncton

Ontario

Bob Vautour Moncton

661670

2012

01

19

Sprott 2012 Flow-Through Limited Partnership

Saint John

Ontario

Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John

661716

2012

01

23

QWEST 2012 OIL & GAS FLOWTHROUGH LIMITED PARTNERSHIP

Saint John

Stewart McKelvey ColombieCorporate Services Britannique / British Columbia (NB) Inc. Saint John

661743

2012

01

24

Department of Environment

Ministère de l’Environnement

NOTICE UNDER THE COMMUNITY PLANNING ACT PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under the Community Planning Act, subsection 77(2.96), Ministerial Regulation for the Chamcook Planning Area under the Community Planning Act, being Ministerial Regulation 11-CHA-036-00, otherwise cited as the Chamcook Planning Area Rural Plan Regulation - Community Planning Act, was enacted by the Minister of Environment on January 16, 2012 and filed in the Charlotte County Registry office on January 24, 2012 under official number 31089155.

AVIS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR L’URBANISME AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LES PRÉSENTES, conformément au paragraphe 77(2.96) de la Loi sur l’urbanisme, qu’un règlement ministériel pour du secteur d’aménagement de Chamcook, établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, soit le Règlement ministériel 11-CHA-036-00, autrement cité comme le Règlement établissant le plan rural du secteur d’aménagement de Chamcook - Loi sur l’urbanisme, a été adopté par la ministre de l’Environnement le 16 janvier 2012 et a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de Charlotte le 24 janvier 2012 sous le numéro 31089155.

Department of Justice and Consumer Affairs

Ministère de la Justice et de la Consommation

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, chapter C-32.2, that the Caisse populaire Sud-Est Ltée has amended its articles effective December 23, 2011.

Sachez, en vertu du sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2, que la Caisse populaire Sud-Est Ltée a modifié ses statuts en date du 23 décembre 2011.

Pierre LeBlanc, CA Superintendent of Credit Unions

Le surintendant des caisses populaires Pierre LeBlanc, c.a.

________________

________________

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, Chapter C-32.2, that La Caisse Populaire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaire Kent-Centre Ltée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caisse populaire Kent-Sud Ltée, and Caisse populaire Sud-Est Ltée have amalgamated effective the 1st day of January, 2012 under the name Caisse populaire Sud-Est Ltée and that the provisions of the Credit Unions Act have been complied with.

Sachez que, conformément au sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2, La Caisse Populaire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaire Kent-Centre Ltée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caisse populaire KentSud Ltée, et Caisse populaire Sud-Est Ltée ont fusionné pour devenir à compter du 1 janvier 2012 Caisse populaire Sud-Est Ltée et que toutes les dispositions de la Loi sur les caisses populaires ont été respectées.

Pierre LeBlanc, CA Superintendent of Credit Unions

Le surintendant des caisses populaires Pierre LeBlanc, c.a.

The Royal Gazette — February 22, 2012

312

Gazette royale — 22 février 2012

New Brunswick Securities Commission

Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick

REQUEST FOR COMMENTS Notice and Request for Comment – Publishing for comments:

DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis de consultation et demande de commentaires – Publication en vue de recueillir des commentaires sur : • le projet de la Norme multilatérale 32-102 sur les dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents (NM 32-102); • le projet de l’Instruction complémentaire 32-102IC (32-102IC); et • les modifications corrélatives proposées à l’Instruction complémentaire 31-103IC relative à la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (31-103IC) (collectivement, les textes proposés).

• proposed Multilateral Instrument 32-102 Registration Exemptions for Non-Resident Investment Fund Managers (MI 32-102); • proposed Companion Policy 32-102CP (32-102CP); and • proposed consequential amendments to Companion Policy 31-103CP Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (31-103CP) (together, the Proposed Materials). Introduction On January 23rd, 2012, the New Brunswick Securities Commission (Commission) approved publication in order to obtain comments on the Proposed Materials.

Introduction Le 23 janvier 2012, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (Commission) a autorisé la publication en vue de recueillir des commentaires sur les textes proposés.

Summary of Proposed Materials MI 32-102 and 32-102CP would apply in Ontario, Québec, New Brunswick and Newfoundland and Labrador (the jurisdictions) and relate to proposed registration exemptions for investment fund managers that do not have their head office or their principal place of business in a jurisdiction of Canada and that do not have a place of business in the local jurisdiction (nonresident investment fund managers).

Résumé des textes proposés NM 32-102 et 32-102IC s’appliqueraient en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les territoires) et établiraient des dispenses d’inscription pour les gestionnaires de fonds d’investissement qui n’ont pas leur siège ou leur établissement principal situé dans un territoire du Canada et qui n’ont pas d’établissement dans le territoire intéressé (les gestionnaires de fonds d’investissement nonrésidents). La règle proposée dispenserait les gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents de l’obligation de s’inscrire dans les territoires lorsqu’il n’y a pas de facteur de rattachement significatif avec le territoire intéressé. NM 32-102 prévoit une dispense de l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement dans le cas où il n’y a aucun porteur du fonds d’investissement ou démarchage actif de résidents dans le territoire intéressé. 32-102IC fournit des indications sur ce qui serait considéré ou non comme du démarchage actif. La règle proposée prévoit également une dispense dans le cas où le placement des titres du fonds au Canada se serait limité à des clients autorisés Le but de la modification corrélative de l’article 7.3 de 31-103IC est de renvoyer les lecteurs aux indications concernant l’obligation d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents.

MI 32-102 would exempt non-resident investment fund managers from the requirement to register in the jurisdictions in circumstances where there are no significant connecting factors to the local jurisdiction. The Proposed Materials include an exemption from the investment fund manager registration in circumstances where there are no security holders of the investment fund, or active solicitation of residents, in the local jurisdiction. 32-102CP provides guidance on what would and would not be considered active solicitation. The proposed rule also provides an exemption in circumstances where the Canadian distribution of the fund’s securities would be restricted to permitted clients. The purpose of the proposed consequential amendment to section 7.3 of 31-103CP is to provide references to applicable guidance on the registration requirement for non-resident investment fund managers. Request for Comment The Commission welcomes your comments on the Proposed Materials as they apply to New Brunswick only.

Demande de commentaires La Commission désire prendre connaissance de vos commentaires au sujet des textes proposés mais uniquement dans la mesure où cela s’applique au Nouveau-Brunswick.

The Royal Gazette — February 22, 2012

How to Obtain a Copy and Provide your Comments The text of the Proposed Materials as well as a more detailed notice can be obtained from the Commission website at: www.nbsc-cvmnb.ca.

313

Gazette royale — 22 février 2012

Pour prendre connaissance des documents et nous faire part de vos commentaires On trouvera les documents énoncés ci-dessus ainsi qu’un avis plus détaillé par l’entremise du site web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca.

A paper copy of the Proposed Materials may be obtained by writing, telephoning or e-mailing the Commission. Comments are to be provided, in writing, by no later than April 10th, 2012, to:

On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission. Veuillez nous faire part de vos commentaires par écrit au plus tard le 10 avril 2012 à l’adresse suivante :

Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within N.B. only) Fax: 506-658-3059 E-mail: [email protected]

Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires that a summary of the written comments received during the comment period be published.

Nous sommes incapables de garantir la confidentialité des commentaires formulés, étant donné que les mesures législatives sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent que soit publié un résumé des observations écrites qui sont reçues au cours de la période de consultation.

Questions If you have any questions, please refer them to:

Questions Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :

Kevin Hoyt Director, Regulatory Affairs New Brunswick Securities Commission Tel: 506-643-7691 Email: [email protected]

Kevin Hoyt Directeur des affaires réglementaires Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick Téléphone : 506-643-7691 Courriel : [email protected]

Notices of Sale

Avis de vente

TO: FLOYD JOSEPH GALLANT AND MARIE NORMA GALLANT, Mortgagors; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 10 Hamilton Beach Road, Charlo, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 50068675. Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINION BANK. The sale is scheduled for Thursday, March 22, 2012, at 11:00 a.m., at the Campbellton Court House, 157 Water Street, Campbellton, New Brunswick.

DESTINATAIRES : FLOYD JOSEPH GALLANT ET MARIE NORMA GALLANT, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 10, chemin Hamilton Beach, Charlo, province du Nouveau-Brunswick, et ayant le numéro d’identification parcellaire 50068675. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le jeudi 22 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Campbellton, 157, rue Water, Campbellton (Nouveau-Brunswick).

The Royal Gazette — February 22, 2012

314

Gazette royale — 22 février 2012

See advertisements in The Tribune in the issues of February 24, March 2, March 9 and March 16, 2012.

Voir l’annonce publiée dans les éditions du 24 février et des 2, 9 et 16 mars 2012 du Tribune.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)

Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust)

________________

________________

TO: RÉJEAN GEORGE COMEAU AND SOPHIE ROY, Mortgagors; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 203 Marie Street, Beresford, in the County of Gloucester, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 20774998. Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINION BANK. The sale is scheduled for Wednesday, March 21, 2012, at 11:00 a.m., at the Bathurst Court House, 254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. See advertisements in The Northern Light, in the issues of February 21, February 28, March 6 and March 13, 2012. DATED this 25th day of January, 2012.

DESTINATAIRES : RÉJEAN GEORGE COMEAU ET SOPHIE ROY, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 203, rue Marie, Beresford, comté de Gloucester, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 20774998. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le mercredi 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 21 et 28 février et des 6 et 13 mars 2012 du Northern Light. FAIT le 25 janvier 2012.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: ROBERT M. CREAMER, Solicitors for THE TORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)

ROBERT M. CREAMER, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de LA BANQUE TORONTODOMINION (TD Canada Trust)

________________

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Darren Robert Hanselpacker and Julie Marie Hanselpacker, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 96 Brunswick Street, St. George, New Brunswick, the same lot conveyed to Darren Robert Hanselpacker and Julie Marie Hanselpacker by Deed registered in the Charlotte County Registry Office on October 22nd, 1999, in Book 703, Pages 355-358, as document number 10572619.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Darren Robert Hanselpacker et Julie Marie Hanselpacker, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 96, rue Brunswick, St. George (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Darren Robert Hanselpacker et Julie Marie Hanselpacker par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Charlotte le 22 octobre 1999, sous le numéro 10572619, aux pages 355 à 358 du registre 703. Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 7 mars 2012, à 11 h, heure locale, au centre de Services Nouveau-Brunswick, situé au 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 février 2012 du Telegraph-Journal.

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee. Sale to be held at the Offices of Service New Brunswick located at 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick on the 7th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated February 7, February 14, February 21 and February 28, 2012. McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095

________________

________________

The Royal Gazette — February 22, 2012

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Jennifer Audrey Stacey, original Mortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 33 Killarney Road, Riverview, New Brunswick, the same lot conveyed to Jennifer Audrey Stacey by Transfer registered in the Land Titles Office on June 27, 2006, as document number 22329297. Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at Moncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, New Brunswick, on the 2nd day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Times & Transcript dated February 2, February 9, February 16 and February 23, 2012.

315

Gazette royale — 22 février 2012

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Jennifer Audrey Stacey, débitrice hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 33, chemin Killarney, Riverview (NouveauBrunswick), correspondant au même lot ayant été transféré à Jennifer Audrey Stacey par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le 27 juin 2006 sous le numéro 22329297. Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente aura lieu le 2 mars 2012, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville de Moncton, situé au 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times & Transcript.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095

________________

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Preston Fraser Hooper, original Mortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 336 Route 785, Utopia, New Brunswick, the same lot conveyed to Preston Fraser Hooper by Transfer registered in the Land Titles Office on September 29, 2003, as document number 17142481.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataire : Preston Fraser Hooper, débiteur hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 336, route 785, Utopia (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Preston Fraser Hooper par l’acte de transfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 29 septembre 2003, sous le numéro 17142481. Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente aura lieu le 7 mars 2012, à 11 h 15, heure locale, au centre de Services Nouveau-Brunswick, situé au 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times & Transcript.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at the Offices of Service New Brunswick located 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick, on the 7th day of March, 2012, at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Times & Transcript dated February 2, February 9, February 16 and February 23, 2012. McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095

________________

________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 304 Debec Road, Debec, New Brunswick, the same lot conveyed to Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs by Transfer registered in the Land Titles Office on August 27, 1999, as document number 10444645.

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 304, chemin de Debec, Debec (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le 27 août 1999, sous le numéro 10444645.

The Royal Gazette — February 22, 2012

316

Gazette royale — 22 février 2012

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mortgagee. Sale to be held at the Woodstock Court House located at 689 Main Street, Woodstock, New Brunswick on the 6th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Bugle-Observer dated February 7, February 14, February 21 and February 28, 2012.

Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h, heure locale, au palais de justice de Woodstock situé au 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 février 2012 du BugleObserver.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation, Per: T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street, P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société hypothécaire Scotia, Barker House, bureau 600, 570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (NouveauBrunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur : 506-458-9903

________________

________________

TO: BRUCE D. HEPPERLE/BRUCE DARWIN HEPPERLE and CAROLE J. HEPPERLE/JEANNINE CAROLE HEPPERLE, of 450 Route 628, Penniac, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagor;

DESTINATAIRES : BRUCE D. HEPPERLE/BRUCE DARWIN HEPPERLE et CAROLE J. HEPPERLE/ JEANNINE CAROLE HEPPERLE, du 450, route 628, Penniac, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires; LA BANQUE ROYALE DU CANADA, 504, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G1, titulaire de la première hypothèque; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 450, route 628, Penniac, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par Secure Capital MIC Inc., titulaire de la deuxième hypothèque. La vente aura lieu le 20 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Fredericton situé au 427, rue Queen, Fredericton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner.

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 504 Queen Street, Fredericton, New Brunswick, E3G 5G1, Holder of the First Mortgage; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 450 Route 628, Penniac, County of York and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by Secure Capital MIC Inc., holder of a second mortgage. Sale on the 20th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., at the Fredericton Court House located at 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick. See advertisement in The Daily Gleaner. MacLean Law, Solicitors for the Mortgagee, Secure Capital MIC Inc.

MacLean Law, avocats du créancier hypothécaire, Secure Capital MIC Inc.

________________

________________

The sale is scheduled for Friday, March 23, 2012, at 11:00 a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick. See advertisements in the Times & Transcript in the issues of February 22, February 29, March 7 and March 14, 2012.

DESTINATAIRE : JESSIE JAMES SAUNDERS, débiteur hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 11, chemin Leo, Shediac River, comté de Westmorland, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 70095021. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le vendredi 23 mars 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 22 et 29 février et des 7 et 14 mars 2012 du Times & Transcript.

TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)

Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust)

________________

________________

TO: JESSIE JAMES SAUNDERS, Mortgagor; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 11 Leo Road, Shediac River, Westmorland County, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70095021. Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The Royal Gazette — February 22, 2012

To: ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANC ESCALIERS CERAMIQUE LTÉE, 4024 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, Gloucester County and Province of New Brunswick, Mortgagor; CBDC Peninsule Acadienne Inc., subsequent Mortgagee;

317

Gazette royale — 22 février 2012

Sale to be held on the 6th day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Saint-Isidore Municipal Building, located at 3906 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, in the County of Gloucester, New Brunswick. SEE ADVERTISEMENT IN L’ACADIE NOUVELLE.

Destinataire : ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANC ESCALIERS CERAMIQUE LTÉE, 4024, boulevard des Fondateurs, à Saint-Isidore, comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire; CBDC Péninsule Acadienne Inc., créancière hypothécaire subséquente; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Bien en tenure libre situé au 4024, boul. des Fondateurs, à Saint-Isidore, dans le comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick. AVIS DE VENTE donné par la Caisse Populaire Le Lien d’Or Limitée, maintenant connu sous le nom de Caisse populaire le Lien des deux Rivières Ltée suite à une fusion en date du 1er janvier 2012, titulaire de la première hypothèque en vertu du pouvoir de vente contenu dans l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens. La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h à l’entrée de l’édifice municipal du village de Saint-Isidore, situé au 3906, boulevard des Fondateurs, à Saint-Isidore, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick. VOIR L’ANNONCE DANS L’ACADIE NOUVELLE.

JONATHAN ROCH NOËL, Solicitor for Caisse Populaire le Lien des deux Rivières Ltée

JONATHAN ROCH NOËL, avocat pour la Caisse Populaire le Lien des deux Rivières Ltée

________________

________________

To: Romain Georges Murray, of the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, and Marie Monique Murray, of the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, Mortgagors; And to: All others whom it may concern. Freehold premises situate, lying and being at 1690 Sunset Drive, in the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, PID 20614665. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage. Sale on the 22nd day of March, 2012, at the hour of 11:00 o’clock in the forenoon, at the Court House in Bathurst, 254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in The Northern Light.

Destinataires : Romain Georges Murray, de la ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, et Marie Monique Murray, de la ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires; Et tout autre intéressé éventuel. Lieux en tenure libre situés au 1690, promenade Sunset, ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 20614665. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 22 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans The Northern Light.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

________________

________________

TO: DUANE ALEXANDER GEIKIE, of 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Mortgagor; AND TO: EVA GEIKIE, of 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Spouse of Duane Alexander Geikie; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises known as PID 40164014, situate, lying and being at 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder of the first mortgage.

DESTINATAIRES : DUANE ALEXANDER GEIKIE, du 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; EVA GEIKIE, du 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, conjointe de Duane Alexander Geikie; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification est 40164014. Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titulaire de la première hypothèque.

AND TO ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 4024 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, Gloucester County and Province of New Brunswick. NOTICE OF SALE given by Caisse Populaire Le Lien d’Or Ltee, now known as Caisse populaire le Lien des deux Rivières Ltée following an amalgamation on January 1st, 2012, as Mortgagee and Holder of the First Mortgage by virtue of the power of sale contained in the mortgage and the Property Act.

The Royal Gazette — February 22, 2012

Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the County Court House, 673 King George Highway, Miramichi, New Brunswick. See advertisement in the Miramichi Leader. Sale conducted under the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.

318

Gazette royale — 22 février 2012

DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.

La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice du comté, 673, route King George, Miramichi (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans le Miramichi Leader. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitre P-19. FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.

WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, The Toronto-Dominion Bank

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire, La Banque Toronto-Dominion

________________

________________

TO: MICHAEL IAN MACKINNON, of 1061 McLeod Hill Road, McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagor; TO: CANADA REVENUE AGENCY, of 126 Prince William Street, Saint John, in the Province of New Brunswick; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises known as PID 75156539, situate, lying and being at 1061 McLeod Hill Road, McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder of the first mortgage. Sale on the 19th day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Fredericton Court House, 427 Queen Street, in the City of Fredericton, in the County of York, New Brunswick. See advertisement in The Daily Gleaner. Sale conducted under the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended. DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.

DESTINATAIRES : MICHAEL IAN MACKINNON, du 1061, chemin de McLeod Hill, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; AGENCE DU REVENU DU CANADA, 126, rue Prince William, Saint John, province du Nouveau-Brunswick; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 1061, chemin de McLeod Hill, McLeod Hill, comté de York, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 75156539. Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 19 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen, ville de Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitre P-19. FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.

WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, The Toronto-Dominion Bank

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire, La Banque Toronto-Dominion

________________

________________

To: Gary Stephen Siddall and Angela Marie Siddall, of Belleville, in the County of Carleton and Province of New Brunswick, Mortgagors; And to: Royal Bank of Canada, c/o Cox & Palmer, 644 Main Street, Moncton, New Brunswick, E1C 1E2, Judgment Creditor; And to: All others whom it may concern. Freehold premises situate, lying and being at 268 McLellan Road, Belleville, in the County of Carleton and Province of New Brunswick, PID Number 10149342. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage.

Destinataires : Gary Stephen Siddall et Angela Marie Siddall, de Belleville, comté de Carleton, province du NouveauBrunswick, débiteurs hypothécaires; Banque Royale du Canada, a/s de Cox & Palmer, 644, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2, créancière sur jugement; Et tout autre intéressé éventuel. Lieux en tenure libre situés au 268, chemin McLellan, Belleville, comté de Carleton, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 10149342. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque.

The Royal Gazette — February 22, 2012

Gazette royale — 22 février 2012

319

Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Court House in Woodstock, 689 Main Street, Woodstock, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in The Bugle.

La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans The Bugle.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

________________

________________

TO: Charles James Donaher, of Targetville, in the County of Kent and Province of New Brunswick, Mortgagor; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 2710 Route 510, Targetville, in the County of Kent and Province of New Brunswick, also known as PID #25279803. Notice of Sale given by Advance Savings Credit Union Limited (formerly Rexton Credit Union Limited), holder of the first mortgage. Sale on the 4th day of April, 2012, at 11:00 a.m., at the Bouctouche Town Hall, 211 Irving Boulevard, Bouctouche, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Times & Transcript.

DESTINATAIRE : Charles James Donaher, de Targetville, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 2710, route 510, Targetville, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 25279803. Avis de vente donné par Advance Savings Credit Union Limited (anciennement Rexton Credit Union Limited), titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 4 avril 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville de Bouctouche, 211, boulevard Irving, Bouctouche (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Times & Transcript.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, Advance Savings Credit Union Limited

Cox & Palmer, avocats du créancier hypothécaire, Advance Savings Credit Union Limited

Notice to Advertisers

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’s Printer Office, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Queen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees:

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill Originating process Order of a court Notice under the Absconding Debtors Act Notice under the General Rules under the Law Society Act, 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission Notice of examination under the Licensed Practical Nurses Act Notice under the Motor Carrier Act

Cost per Insertion $ 20 $ $ $ $

25 25 20 20

$ 25 $ 30

Avis Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé Acte introductif d’instance Ordonnance rendue par une cour Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite Avis de radiation ou de suspension ou de demande de réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers

Coût par parution 20 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $

25 $ 30 $

The Royal Gazette — February 22, 2012 Any document under the Political Process Financing Act

$ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)

$120

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété

20 $ 20 $ 120 $

(Formule 70B) Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) Notice of a correction

$ 20

Any other document

Gazette royale — 22 février 2012

320

charge is the same as for publishing the original document $3.50 for each cm or less

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) Avis d’une correction

Tout autre document

20 $ 75 $ 20 $ les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations.

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at:

La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ attorney general/royal gazette.html

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ procureur general/gazette royale.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13% tax, plus shipping and handling where applicable.

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention.

Office of the Queen’s Printer 670 King Street, Room 117 P.O. Box 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899 E-mail: [email protected]

Bureau de l’Imprimeur de la Reine 670, rue King, pièce 117 C.P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899 Courriel : [email protected]

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK

© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés