The Royal Gazette
Gazette royale
Fredericton New Brunswick
Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428
Vol. 170
Wednesday, February 22, 2012 / Le mercredi 22 février 2012
Notice to Readers
291
Avis aux lecteurs
The Royal Gazette is officially published on-line.
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis.
Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372.
Business Corporations Act
Loi sur les corporations commerciales
Notice of a decision to dissolve provincial corporations and to cancel the registration of extra-provincial corporations
Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales et d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales
Notice of decision to dissolve provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to dissolve the following corporations pursuant to paragraph 139(1)(c) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the corporations.
Avis d’une décision de dissoudre les corporations provinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision de dissoudre les corporations suivantes en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites corporations.
The Royal Gazette — February 22, 2012 001391 038942 044089 049322 056706 059477 059744 059754 501733 503510 504286 506552 506590 508722 508864 508894 508917 514004 514065 514083 600312 604255 605789 611688 624417 624457 630618 630640 630673 630674 630736 630952 636307 637011 637069 637115 637144 637164 637192 637428 643297 643314 643322 643533 643584 643619 643643 649325 649677 649679 649681 649719 649761 649778 649789 649808 649810 649811 649812 649821 649858 649886 649912 649972 649975 650076 650086 650089 650100 650139 650148 650163 650210 044160 649801
001391 N.B. LTD. 038942 N.B. LTD. 044089 N.-B. LTEE 049322 N.B. LTEE/LTD 056706 N.-B. LTEE 059477 N.-B. INC. 059744 N.B. LTD. 059754 N.B. INC. 501733 N.B. LTD. 503510 N.B. LTD. 504286 NB INC 506552 N.B. INC. 506590 N.B. LTD. 508722 N.B. LTD. 508864 NB Ltd. 508894 N.B. LTD. 508917 N.B. INC. 514004 N. B. Ltd. 514065 N.B. Ltd. 514083 N.B. Inc. 516355 N.B. LTD. 604255 N.B. Ltd. 605789 N.B. Inc. 611688 N.B. Ltd. 624417 NB Corp./ 624417 N.-B. Corp. 624457 N.B. Ltd. 630618 NB INC. 630640 NB Ltd. 630673 N.B. Ltd. 630674 N.B. Ltd. 630736 N.-B. Ltée 630952 N.B. Inc. 636307 NB LTD 637011 N.B. Ltd. 637069 NB Inc. 637115 N.B. Inc. 637144 N.B. Ltd. 637164 N.B. INC. 637192 NB INC. 637428 NB Inc. 643297 N.B. Inc. 643314 NB Inc. 643322 N.B. Ltd. 643533 New Brunswick Corporation 643584 New Brunswick Ltd. 643619 NB Inc. 643643 NB LTD. 649325 NB LTD. 649677 NB Ltd. 649679 N.B. Ltd. 649681 N.B. Inc. 649719 N.B. Inc. 649761 N.B. Ltd. 649778 N.B. Ltd. 649789 N.B. LTD. 649808 N.B. Inc. 649810 N.-B. Inc. 649811 NB Inc. 649812 N.B. Inc. 649821 N.-B. Corp. 649858 N.B. Ltd. 649886 NB INC. 649912 NB LIMITED 649972 NB Inc. 649975 NB Ltd. 650076 NB Inc. 650086 N.B. INC. 650089 N.B. LTD. 650100 N.B. Ltd. 650139 N.B. Inc. 650148 NB INC. 650163 N.B. Ltd. 650210 NB Ltée 650210 NB Ltd. A & M HOLDINGS INC. Abdullah Alsaghir M.D. Professional Corporation 617566 ABER INDUSTRIES INC. 636995 Abiron Enterprises Ltd. 059620 ABOVO CONSTRUCTION INC.
Gazette royale — 22 février 2012
292 617441 ACADIAN STURGEON AND CAVIAR INC. 649690 Accent International Inc. 649614 ACR Framing Ltd. 048730 ADAM CANADA LTD. 650207 AER Industries Inc. 000086 AHE PLUMBING & HEATING LTD. 516334 AKITA (NB) BASEMENT SYSTEMS INC 637068 ALG Holdings Ltd. 630573 ALIGN PEOPLE RESOURCES LTD. 506675 ALL NIGHT ALL DAY INC. 643427 ALL SEA ATLANTIC LTD. 637184 ALREADY RITCHIE PROPERTIES LTD. 624542 Altimed Auto Repair Ltd 630693 AMEYA INTERNATIONAL INC. 047016 AQUILA TECHNOLOGIES INC. 637142 AR.RO Realty Inc. 039104 ATLANTIC CANADIANS HOCKEY CLUB INC./CLUB DE HOCKEY CANADIENS DE L’ATLANTIQUE INC. 511510 ATLANTIC FORESTRY SERVICES LTD. 511550 AUBE’S FOODS LTD. 511472 Audfroid Consultants Ltd. 650167 Ava Capital Markets Canada Ltd. 649758 AVALIS SOLUTIONS LTD. 643692 Avatar Human Resources Consulting Ltd. 643353 Azure Sky Films Inc. 624448 B & M Specialized Automotive Services Inc. 650103 B.A.D.A.S. HOLDINGS INC. 643805 BART GORMAN ENTERPRISES LTD. 051510 BARTHOLOMEW ENTERPRISES INC. 508907 BAYSIDE BULK TERMINAL CORPORATION 001613 BAYSIDE STEVEDORING LTD. 649855 Benji Hawkes Drywall & Crackfill Ltd. 617904 BETCO HAULAGE LTD. 033450 BIRD’S CORNER STORE LTD. 033335 BOUCHARD & FRERES CONSTRUCTION LTEE 506624 BRIKSON COMPUTER CABLING LTD. 637195 BROOKS HOMES LTD. 643441 BRUNO ARSENEAU LIVRAISON INC. 036919 BRUNSWICK ASSOCIATES LTD. 002648 C. & D. CONSTRUCTION LIMITED 617486 C. A. Crawford Insurance Inc. 649892 Callstar Marketing Ltd. 650085 Cambridge Equipment Corp. 649783 Camp à Joe inc. 504365 CAPE HOG FARM INC. 044500 CARCROFT HOLDINGS INC. 649889 Cardwell Compost (Asia) Inc. 636941 Carleton International Ltd 630875 Carleton Listings Inc. 511608 CASTLEHILL PROPERTY MANAGEMENT LTD. 600168 CENTRAL SIDING LTD. 003442 CHALEUR VIEW FARM SYNDICATE LTD. 031645 CHAMCOOK ASSOCIATES LTD. 650078 Chameleon Electronic Security Inc. 059604 CHANCE HARBOUR AQUACULTURE AND FISHERIES INC. 502004 CHAUSSURES JOCELYNE LTEE. 649745 CHDM - Oil Canada Inc. 506711 CHERISHED PET MEMORIAL SERVICES LTD. 501800 CHIASSON AQUACULTURE LTEE 043445 CHIASSON MEUBLES MODERNES LTEE 051610 CHIPPIN & DEWITT ASSOCIATES, INC. 003818 CLOVER CONSTRUCTION LTD. 003950 COATES AND HAINES LTD.
649860 046418 504302 514041 636943 053793 649864 624606 650028 511533 605626 650105 649734 502024 617754 624582 514052 643292 643828 605564 630669 049441 605879 514135 637064 643298 637112 649646 649954 624503 008636 643508 508881 624383 643882 504403 630968 611471 643320 059607 643277 047076 511498 617608 617473 605985 643497 501957 501958 007081 617664 630545 637196 611716 630656 059816 059666 650054 051616 611579 624510
Community First Funeral Home Inc. COMPASS MARINE LIMITED COOL SIDE REFRIGERATION LTD. CORPORATE HEROES INTERNATIONAL INC. CSLB Holdings Ltd. CURRY COVE SALMON LTD. D & C Salvage Ltd. Dan Guimond Auto Sales Inc DCAM Productions Ltd. DEBORAH O’LEARY, M.D. PROFESSIONAL CORPORATION Delphinium Ltée Delta Light Canada Inc. DeLuca Corp. DEPANNEUR CHEZ RACHEL LTEE DEVELOPMENTBOX INC. DION-MAHANEY DRYWALL NB LTD. DOUBLE R FISHERIES LTD. DR. AKMAL GHAFOOR PROFESSIONAL CORPORATION Dr. German W. Blando cp inc. DR. GILBERT DRU CORPORATION PROFESSIONNELLE INC. Dr. J. J. Morales Professional Corporation DR. J.C.W. PARROTT PROFESSIONAL CORPORATION Dr. Jean-François Guité Corporation Professionnelle Inc. DR. RONALD HAREBOTTLE PROF. CORP. DR. SYED AHMED & DR. NAJNEEN AHMED PROF. CORP. DREAM MAKERS RECREATION INC. DURELLE’S PEST MANAGEMENT LTD. Durrani & Webb Holdings Ltd ECKO SOLUTION PLUS INC. Entreprise C.D.G.M. Enterprise Inc. EPICERIE R.H. CLAVETTE INC. EXCELL PERMITS & PILOT VEHICLES LTD. Exigen (Canada), Inc. FAUNE HERITAGE WILDLIFE INC. FOAM FREE DRAUGHT EXPERTS INC. FORESTERIE G.L. INC. Foresterie Robichaud Inc. Fundy Minerals Ltd Future Metal Roofing Inc. G. BOUDREAU HOLDING INC. G. Bourque Deliveries Ltd. G. S. MACDIARMID PROFESSIONAL CORPORATION G.G. VENTURES LTD. G.G.Y. Trucking Ltd. G.K. HOLDINGS LTD. Garage Laurie Inc. GARTH POWER TRUCKING LTD. GEO-MAR INC. GEORGE T. YEAMANS PROFESSIONAL CORPORATION INC. GESTION ACADIENNE LTEE ACADIAN MANAGEMENT LTD Gestion YR Ltée GOLBAD DISTRIBUTION SERVICES LTD Gold Sun Media Inc. Golf 101 Inc. Gordon Sharpe Enterprises Inc. GREAT CIRCLE MARINE SERVICES INC. GREEN SHORES ESTATES INC. Green Water Diving Inc. GTA CONSULTANTS INC. GUYCHEM INC. Hansen International Inc
The Royal Gazette — February 22, 2012 649630 HFHG Consulting Inc. 053811 HIGGINS GENERAL INSURANCE LTD. 053780 HILLDALE POTATO INC. 031608 HORIZON ENTERPRISES LTD. 649820 Hotchkiss Home Furnishings Ltd. 617447 Howard Brook Development Inc. 008236 HOYT’S SEPTIC SERVICES LTD. 008237 HOYT’S SUPERMART LTD. 650075 HRMS Solutions, Inc. 617505 HYDRO CLEAN INC. 611556 I.M.S.G. INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS GROUP INC. 649750 IMT Training Services Inc. 630720 Inevitable Holdings Corp. 649844 INFORMATICS TERAFLOP CENTRAL INC. 631002 Ingallwood Manufacturing Inc 611211 InteliConnect Ltd. 650023 Iron Hill Holdings Ltd. 643394 IT Equipment Xpress Ltd. 649615 J & L ENERGY INC. 031681 J. E. & R. GODIN & FILS LIMITEE 630861 J.A.L. Janitorial Ltd. 649779 JACKY’S BAR INC. 637424 Janus Project Management Services Ltd. 059727 JARROSS INVESTMENTS LTD. 630797 JEANNINE & ROBERT TOURS INC. 611560 Jeremiah Jacobs Ltd. 643285 JJL HOLDING INC. 611646 John D. Boyd Plumbing & Heating Ltd. 053763 JOS S. LEGER & SON TRUCKING LTD. 637235 Joshua Investments Inc. 511476 JPM ENTERPRISES INC. 630686 JSM HOLDINGS INC. 051576 JW Walsh & Son Transportation Services Inc. 013256 K. W. POND LIMITED 514115 K.C. HOWE HOLDINGS LTD. 600074 KA KA GOOSE INC. 605853 KATERA INDUSTRIES INC. 643295 Kings Point Productions Inc. 611472 KNOWLEDGE ATLAS INC. 508895 KRISHNA SAI INC. 649743 KVT TRUCKING INC. 009472 LAIRD’S CONSTRUCTION LTD. 049471 LAM & ASSOCIATES LIMITED 643444 Lan-Bert Homes Development Ltd. 630949 Land and Sea Training Ltd. 511479 LATIF PIZZA & DONAIR LTD. 513202 Les Entreprises R.E.H. Fournier Ltée 013382 LES PRODUCTEURS D’ARBRES DE NOEL CLAIRE-FONTAINE LTEE. 642921 LL BRANCH CONSULTANTS INC. 624193 Logroty Inc. 049480 LOSIER STATION SERVICE LTEE 056766 LOUMAREX INC. 508850 M & W CONTRACTING LTD. 649963 M. J. Roy Foundation NB Inc. 617663 M.S.T. Consulting Inc. 010254 MABIE INVESTMENTS LTD. 637154 MacLeod Agronomics Ltd. 036961 MAK BROTHERS LTD. 650209 MakCass Management Inc. 643737 Marathon Canada Imports Ltd. 010443 MARCHE B. PAULIN LTEE 036897 MARIETTE ENTREPRISES LTEE 051625 MARITIME WATER TREATMENT LTD.
Gazette royale — 22 février 2012
293 624413 639773 059499 011777 010838 650102 038618 617966 624279 600260 030237 041451 617474 637328 600242 511467 011319 650142 511404 637357 502019 630676 504270 513941 637362 514029 649754 012798 053761 649732 649605 511366 650108 649645 649644 059763 508985 013311 036998 649152 624391 611525 013518 637262 611417 650144 605855 041653 617461 637122 508956 643733 643756 013979 046956 014025 014029 014144 650088
Maritime Window Defogger Inc. MaRusCo Enterprise Ltd. MATHIS INSTRUMENTS LTD. MCLEAN’S AUTOMOTIVE LTD. MELANSON PLUMBING & HEATING LTD. Mereah Land Services Ltd. METRO PROCESS SERVERS LTD. MICHAUD HOLDINGS (2005) LTD MICHEL BERUBE FORESTRY INC. MIKKEMA INTERNATIONAL INC. MIRAMICHI FOREST ENTERPRISES LTD. MIRAMICHI TAVERN & CLUB LTD. MISTER RENOVATIONS LTD. MITCHCO WELDING & CONTRACTING INC. Modern Masonry Inc. MOE’S ELECTRIC LTD. MONCTON UNION CENTRE LTD. MSP Drywall Ltée MSSI HOLDINGS INC. Muir Bros. Services Ltd. N.R. HOLDINGS LIMITED New Age Glass Repair Inc. NEWMAN & CO. INC. NORTH STAR HOLDINGS LTD. NORTHUMBERLAND WOODLOT ENTERPRISES INC. OCEAN LEGACY INC. On The Way Gifts & Things Inc. PARK CHEDIK LTD.-PARC CHEDIK LTEE PASSEKEAG PHEASANTS LTD. Perkfection Coffee Ltd. PES Parking Enforcement Solutions Inc. PHYSIO PÉNINSULE INC. PIBM Renovations Inc. PIRET (EDMONTON AVENUE) LEASEHOLD INC. PIRET (NB) HOLDINGS INC. PLASTER ROCK GYPSUM & MANUFACTURING LTD. POINTE-SAPIN AUTO PARTS LTD./ PIECES D’AUTO POINTE-SAPIN LTEE PRECISE SURVEYS LTD. PRECISION EDGE LTD. PREFERRED PAVING AND CONSTRUCTION (2010) LTD. Pro Edge Sports Moncton Ltd. QUACO DUCK FISHERIES LTD. QUALITY SOUND ALARM LTD. R & B Watch & Jewellery Ltd. R YOUNG INDUSTRIAL LIMITED R. Boudreau Tree Trimming Ltd R.L.M. Fisheries Ltd. R.M. WATSON AGRI-CONSULTING LTD. Rebound Holdings Ltd. Remorquage Edmundston Towing Inc. Resto Grec Inc RESTO-BAR LE DECK INC. Richard Development Consulting Inc. RICHARD FARMS LIMITED RIDELL HOLDINGS LTD. RIDGEVIEW ENTERPRISES LTD. RIDGEWOOD FARMS LIMITED RIVIERA CONSTRUCTION LTD./ RIVIERA CONSTRUCTION LTEE S&S LANDSCAPING LTD.
053671 624463 514151 014855 030213 643570 636990 630853 624665 015383 630816 624254 649830 617977 611262 049110 044468 031651 611398 611229 516313 053668 650160 511512 637062 650196 504424 649961 650106 508943 617945 046719 650161 611410 016118 605644 624543 059750 643480 514227 030198 649672 605754 605753 643397 649948 038919 611643 059521 001633 611689 649699 649647 617470 649828 624500 643845 624551 637138 611393 021434
_____________________________________________________
S. & L. REALTY 2000 INC. Saint John Marketers Group Inc. ScarHawk Industries Ltd. SCORPIO INVESTMENTS LTD. Sea-Post Ltd. SHUR-LOCK PARKING AUTHORITY INC. SHUR-WAY INVESTMENTS INC. Silver Maple Developments Inc. SOCIÉTÉ STÉPHANE LOSIER INC. SOUTH BRANCH OROMOCTO LTD. SOUTH DAKOTA URANIUM, INC. SOUTHSIDE MANAGEMENT INC. Speckled Springs Trout Farm Inc. SPRUCEHILL ENTERPRISES LTD. ST-ISIDORE RIDO-DECO LTÉE ST. ANDRE FARMS LTD. St. Ignace Wood Truss Ltd. STAR KEY ENTERPRISES LTD. STEELE VENTURES INC. Sugar House Inc. SULLIVAN LANE FARM LTD. SUPERIOR CONCRETE FINISHING LTD. T & C DUNPHY CONTRACTING LTD. T M T Stable Inc. T-Riple J Holdco Ltd. T.E.R Consulting Inc. TANYA GAYLE ESTATES LTD. THE EMPEROR’S KITCHEN INC. The Finish Guy Inc. The Fishermen’s Anchor Inc. The Gallagher Pub Group Inc. THE KILLAM AGENCY INC. The Reel Review Inc. THE RESULTS COMPANY INC. THERMOFIB LTD./ LTEE THREE GZ INC. THRIFTKING GROUP INC. TONY’S SERVICE STATION (1995) LTD. TOPdesk Canada Corporation Turn of the Century Trolley Tours Inc. U. S. L. RESTORATIONS LTD. Unique Landscaping and Property Management INC. URBAN CONSTRUCTION ATLANTIC LIMITED URBAN DEVELOPMENTS ATLANTIC LIMITED Vanguard Studio Inc. VAPOR GREEN SOLUTION LTD / SOLUTION VAPEUR VERTE LTEE VICKERS POOLS LTD. VISTA BAY MOTORS INC. VU TRUONG RESTAURANT LTD. W. J. BEAIRSTO CO. LTD. W. J. INDUSTRIAL SALES INC. WAKEFORD BUSINESS LTD. Webb & Durrani Holdings Ltd Wee World Inc. WENDOW CORP. West Side Service Center Ltd. Westgate Financial Group Inc. Winchester’s Classic Woman Limited With Power Property Holdings Inc. Wow Now Inc. YOUR CANDLE SHOP LTD.
The Royal Gazette — February 22, 2012 Notice of decision to cancel the registration of extra-provincial corporations Take notice that the Director under the Business Corporations Act has made a decision to cancel the registration of the following extraprovincial corporations pursuant to paragraph 201(1)(a) of the Act, as the said corporations have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may cancel the registration.
624248 637182 636929 073162 649691 649752 649843 643751 624155 077585 018966 077130 647757
2051099 ONTARIO INC. 3101-5837 QUÉBEC INC. 6880061 Canada Ltd. ACME TRUCK LINE, INC. AFS Aerial Photography Inc. AIB INTERNATIONAL CANADA, INC. ATLANTIC CANADA HVAC SERVICES INC. Atlantic Medical Imaging Services Inc. BEN LIVINGSTON AND SONS LIMITED Bristol Group Inc. BUTLER TRUCKING COMPANY COMCARE (CANADA) LIMITED CRS Civilian Regulatory Specialists Inc. / CRS Spécialistes Réglementaires Civil Inc.
Gazette royale — 22 février 2012
294
Avis d’une décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales Sachez que le Directeur, en application de la Loi sur les corporations commerciales, a pris la décision d’annuler l’enregistrement des corporations extraprovinciales suivantes en vertu de l’alinéa 201(1)a) de la Loi, puisque lesdites corporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra annuler l’enregistrement desdites corporations extraprovinciales.
650172 efo Capital Inc. 650079 ÉRABLIÈRE LUC ET CRAIG GAGNON INC 605874 Evans Land Development Limited 600348 FRIENDS OF THE FAMILY ESTATE SERVICES INC. 624274 INTERNATIONAL MUFFLER COMPANY 074556 JEUNIQUE INTERNATIONAL (CANADA) INC. 600542 LASANALTECH INC. 649686 LORBEC METALS LTD. / MÉTAUX LORBEC LTÉE 649635 M & C HESSE TRUCKING LIMITED 076258 MCKEIL MARINE LIMITED 077123 NEWS MARKETING CANADA CORP. 636628 Peake & McInnis Ltd.
643154 624123 611594 650188 649602 647445 073658 076658 649819 650081
PRO FORÊT EXCELLENCE INC. Q1 Labs, Inc. REGAL-BELOIT HOLDINGS LTD. Reinhausen Canada Inc. Shred-it International Inc. Superior Kitchen Designs, Inc. TRUSERV CANADA INC. Tulsa Inc. TUMBLEWIRE INC. WELLINGTON WEST CAPITAL MARKETS INC.
Companies Act
Loi sur les compagnies
Notice of decision to dissolve provincial companies Take notice that the Director under the Companies Act has made a decision to dissolve the following companies pursuant to paragraph 35(1)(c) of the Act, as the said companies have been in default in sending to the Director fees, notices, and/or documents required by the Act. Please note that 60 days after the date of publication of this Notice in The Royal Gazette, the Director may dissolve the companies.
Avis d’une décision de dissoudre les compagnies provinciales Soyez avisé que le Directeur, en application de la Loi sur les compagnies, a pris la décision de dissoudre les compagnies suivantes en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loi, puisque lesdites compagnies ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis par la Loi. Soyez avisé que 60 jours après la date de la publication du présent avis dans la Gazette royale, le Directeur pourra dissoudre lesdites compagnies.
022317 58 LEGION COURT INC. 000701 ARGOSY PUBLICATIONS INC. 023051 ASSEMBLIES OF THE LORD JESUS CHRIST OF NEW BRUNSWICK INC. 624320 ASSOCIATION DES FAMILLES THÉRIAULT DU NOUVEAUBRUNSWICK INC. 643839 Atlantic Fermenters Association Inc. 605740 BATHURST SUPERIOR CAFETERIAS INC. 024153 BELLEDUNE RIVER CEMETERY INC. 023681 BELLEISLE VALLEY RECREATIONAL ASSOCIATION INC. 002919 CANADIAN FORESTRY ASSOCIATION OF NEW BRUNSWICK, INC. 003274 CENTRAL NEW BRUNSWICK WOODMEN’S MUSEUM INC. 003304 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE DIEPPE INC. 003313 CENTRE CULTUREL D’ALLARDVILLE INC. 023117 CLUB DE CURLING TRACADIESHEILA INC. 013318 CLUB RICHELIEU FREDERICTON INC.
636921 Community Homeless Network Inc. / Réseau communautaire des Sans abri. Inc. 025087 COMPASSION SERVICES OF CANADA, INC. 004441 COVENANT REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF NEWCASTLE INC. 600004 DOUGLASTOWN COMMUNITY CHURCH INC. 023891 FUNDY TRAILRIDERS ATV & SNOWMOBILE CLUB INC. 024908 GRACE BAPTIST CHURCH (INDEPENDENT) OF MONCTON, INC. 650175 HAVELOCK HORIZONS INC. 624423 HOPE PARTNERS INTERNATIONAL INC. 600007 Impossible Realities Inc. 008465 INKERMAN RECREATION COUNCIL INC./CONSEIL RECREATIF D’INKERMAN INC. 008714 JACQUET RIVER LIONS CLUB INC. 605759 KENNEBECASIS VALLEY COMMUNITY - CAPACITY CHILDREN INC.
023427 KINETTE CLUB OF THE MIRAMICHI INC. 024364 L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DU CENTRE D’EXCELLENCE DU TOURISME DE L’ATLANTIQUE (AE-CETA) LTÉE 643326 LA MAISON DE LA FAMILLE DE LA PÉNINSULE ACADIENNE INC. 636863 La Solitude de Pré-d’en-Haut Inc. 021803 LEAF TRAILS INC. 022314 LES RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE INC. 022532 Ligne Téléphonique C.A.R.A. Help Line Inc. 022879 METRO HEALTH SERVICES INC. 025580 MIRAMICHI JUNIOR “A” HOCKEY CLUB INC. 609070 New Bandon/Salmon Beach Social Committee Inc. 025582 NEW BRUNSWICK ANTI-POVERTY LEGAL CLINIC INC. 021821 NEW BRUNSWICK LIBRARY TRUSTEES’ ASSOCIATION INC./ L’ASSOCIATION DES COMMISSAIRES DE BIBLIOTHEQUES DU NOUVEAUBRUNSWICK INC.
The Royal Gazette — February 22, 2012 012138 NEW DENMARK HISTORICAL SOCIETY INC. 024906 NEW DENMARK SENIORS’ COMPLEX INC. 600003 Northside Youth Centre Inc. 024716 OPERA NEW BRUNSWICK INC. 024162 PLACE HISTORIQUE DU MADAWASKA INC 600000 Purdy’s Corner Townhouse Association Inc. 023400 RENOUS KNIGHTS CHARITIES INC. 014009 RICHIBUCTO LIONS CLUB INC. 022107 ROTARY CLUB OF BATHURST CHARITY FUND INC.
Gazette royale — 22 février 2012
295 022101 ROTARY CLUB OF GAGETOWN, NEW BRUNSWICK, INC. 018323 ROYAL CANADIAN LEGION MONCTON # 6 014993 SENIOR CITIZENS SERVICES SAINT JOHN INC. 025706 SHEDIAC BAY WATERSHED ASSOCIATION INC./L’Association du bassin versant de la baie de SHEDIAC Inc. 611356 Silicon East Inc. 643713 St. Joseph’s Hospital Auxiliary Inc. 022556 THE CHALEUR GROUND SEARCH AND RESCUE TEAM INC. 617472 THE JOSHUA EVANS’ TRUST INC.
Partnerships and Business Names Registration Act
011864 THE N. B. I. P. CO. EMPLOYEES’ ASSOCIATION INC. 015954 THE TABUSINTAC CLUB, LIMITED 637023 Victoria Park Enhancement Committee 2008 inc. 025715 VICTORIAN ORDER OF NURSES CANADA NEW BRUNSWICK BRANCH INC. 016766 VICTORIAN ORDER OF NURSES, (MONCTON BRANCH), INC. 624535 VICTORY LIGHTHOUSE INC. 016974 WAUKLEHEGAN MANOR INC. 650112 Western Valley Adult Learning Association Inc.
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Partnerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5, the Registrar under the said Act intends to cancel the registration of the certificates of partnership of the firms set forth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of business names of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto by reason of the fact the said firms and businesses have failed to register certificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) or subsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act.
SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a l’intention, en vertu de ladite loi, d’annuler l’enregistrement des certificats de sociétés en nom collectif indiquées à l’annexe « A » ci-jointe et des certificats d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’annexe « B » ci-jointe, en raison du fait que ces firmes ou commerces ont négligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement conformément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de ladite loi, selon le cas.
FURTHER TAKE NOTICE that at any time after the expiration date of thirty (30) days from the date of publication of this Notice, the Registrar may cancel the registration of the said certificates of partnerships and certificates of business names.
SACHEZ AUSSI qu’en tout temps après la date d’expiration de trente (30) jours à partir de la date de publication du présent avis, le registraire peut annuler l’enregistrement desdits certificats de sociétés en nom collectif et certificats d’appellations commerciales.
Schedule “A” / Annexe « A » Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif 629575 629886 629781 629176 629208 351048
Barb’s B & B BLACK BOWSER COMICS Fortune Market KC Solid Surface MARK’S STEAM CLEAN Mountain View A.T.V. Outdoor Adventures
629656 628854 348436 629426 629497
RaJe Informatik Rejuvinate Spa RoMar REAL ESTATE MANAGEMENT ScrapAway SHALLAN & SARA MESSAGE IN A BAG 629285 SHELL CANADA ENERGY
350821 SHELL CANADA PRODUCTS/ PRODUITS SHELL CANADA 629818 Staged Designs 629661 TARGET MAGAZINE 338086 TRIPLE F RANCH
____________________________________________________
Schedule “B” / Annexe « B » Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales 629990 (KCMS) Key Concepts Management Systems 629588 ACADIAN RIM RECYCLING 629736 AFS Leasing 629645 AfterImage New Media 629976 AKELA Canoes 629903 ALBA TOURS 348469 Alliance Flow Products 340870 ALPHAPLEX CUSTOM FABRICATION 629904 ALUMNI HOLIDAYS 353107 AMBER STAINED GLASS
629345 610529 629784 629734 629706 629662 629989 629468
Atlantic Mobility Products Atlantic Towing / Kent Line Operations ATTKINS SOUL Auto Sales Unlimited Auto Stream Avenue Appliances AVENUE MOTORSPORTS Bathurst Mortgage Center/Centre Hypothécaire Bathurst 629805 Bennett Occupational Therapy 629635 Bernie’s Auto Cure 629601 Blue Backyard Consulting
629571 629512 629951 628857 629612 335311 629682 629658 628288 630000 629691 629839
BMC GROUP Brad LeBlanc Enterprises Brafasco BRAKEWHEEL PRODUCTS Bravurin Technologies BRUNSWICK LOAN ACCEPTANCE C.P. COMPUTER DOCTOR Cabinet Kevin J. Haché Cafe-Bistro Mon Ami Canada St. Variety Canadian Green Products Capital ADvice Advertising
The Royal Gazette — February 22, 2012 348539 CAPITAL PEST CONTROL 629905 CARRIES TRAVEL INTERNATIONAL 629992 CHÂTEAU ROYAL: CENTRE DE VILLÉGIATURE FAMILIAL 629993 CHÂTEAU ROYALE: A FAMILY RESORT 330358 CHINA COAST 350863 Claremont Communications 351049 Clinique de Massothérapie de Shédiac Shediac Massage Therapy Clinic 348530 Cobalt60 Design & Graphics 629549 Coiffure Esthetique Sylvie Drouin 629578 COLLETTE CONSULTANT 629970 COMMUNICATIONS COURTCIRCUIT - SHORT CIRCUIT COMMUNICATIONS 629506 Confident Solutions 629586 COOPER FRIDAY’S 629959 COUNTRY ROADS CIDER C0. 353143 COURTENAY INSURANCE AGENCY 629906 CRONOS TRAVELPLAN 629907 CRUISEESCAPES 629769 Dabest IT Consulting 348496 DAVE BALDWIN AUTO SALES 350993 DEBI’S HAIRDRESSING 1409 629752 Decorating Dimensions 350907 Decorative Treasures 629895 Déja vu Second Hand Store 350894 DÉJÀ-VU SIGNS ETC. 348590 DENTS BE GONE 348531 DIANE TERRY, MASSAGE THERAPY 629611 DLA Sales & Marketing 629463 DNR Jewellery Exchange 629657 DOMAINE DE LA VALLÉE DE LACBAKER 629458 DPT SECURITY 629550 East Coast Automotive Warehousing 348429 Edward Hanselpacker Auto Repair 629852 Elbow Grease Welding 337839 EMPIRE ELECTRIC 629812 Ethnic Rainbows Native Cast 319479 EVERY THING WE TOUCH TURNS TO SOLD 629825 Evolution Stone Works 353231 FARRELL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 629871 FIRE READY EXTINGUISHER SALES & SERVICE 348395 FOREMOST INSURANCE 350881 FROG’S PAD 629459 FTI Group 629633 Fundy Alternative Power 627708 Garderie Chez Catherine 629543 Gladstone Alpacas 350663 Gleason Arms 629742 GORDIE’S PUB 629730 Gould’s RenoScaping 629949 Grafton Utility Supply 629953 Grafton Utility Supply (Western) 629950 Grafton West 629584 GULLISON’S COURIER SERVICE 629465 Haddad Marketing 629718 Happy and Healthy Products for Mind, Body and Soul 316673 HARRIS REBAR 629610 Harvest Moon Soap 629941 HD Supply 629942 HD Supply Canada 629946 HD Supply Electrical 629943 HD Supply Facilities Maintenance 629952 HD Supply Fasteners & Tools 629948 HD Supply Utilities 629449 Hoffmann Design 629793 HOUSE OF TUDOR 350990 HUBCAP COMEDY FESTIVAL DE L’HUMOUR
296 629749 629748 629527 629675 629764 629614 629704 629668 629597 629833 353261 629789 629616 348405 629595 629644 350879 629790 629686 629674 629690 350914 629834 629846 629735 629900 629689 629826 629775 629945 629596 629478 629977 629581 629338 629340 629339 629519 629751 629698 350903 346046 629750 629680 629897 629795 353280 629688 629995 629667 629797 629104 629490 629712 350935 629498 629891 629554 629910 629911 629912 629913 629914 629916 629915 629917 629880 314566 314567
HURON DUST CONTROL HURON MATS RENTALS IMAGINiT Technologies Independent Ironworks INDOR MFG. Inner Beauty Esthetics Innovative Interpretations Hospitality Consulting InsTint Window Tinting J.R. LIQUIDATORS JAGUAR CREDIT CANADA LEASING JC Linder Ventures Jeff Bonnar & Son Renovators JFR Communications Julie’s Beau-T Stop Kelly’s Travel And Tours KGM Roofing and Home Improvement KILLAMS WELDING & MACHINING Knotty Girl Fibre Arts KOVACK TREE SERVICES KUTZ FOR MEN KYLE BROWN MEMORIAL FUND L.M.A.C. GOBI LAND ROVER FINANCIAL SERVICES LEASING Laundromat Espresso Bar Lavender Lane Cottage LEELAND TRUCK & EQUIPMENT SALES Lemon Tree Gifts and Crafts Liberty Alliance LITEMOR Litemor Distributors Little Acorns LITTLE JOHN’S VARIETY LJW Choice Consulting Local Moving & Storage Location Crédit Jaguar Canada Location Crédit Mazda Canada Location Services financiers Land Rover Lynch’s Accounting Service Lynne Breen Photography M. P. Creations MAJESTIC JUICES Maliseet Smoke Shop MARCHE INKERMAN ENRG. Marilyn Bustard, Custom Sewing MARINER’S REACH Maritime Precision Industries MARLOG CONSULTING MASCARET MEDIA Master CopyCats Mathis Consultants McDonough Bros. Landscaping Melda’s Art Shop Melvin’s Cafeteria Mike Gould Enterprises MIRAMICHI UNIQUE UNIFORMS MONEY IN YOUR POCKET DEPOT Musée de la Bière My Super Vacations MYALBATOURS MYENCORE CRUISES MYHOLIDAY HOUSE MYNETWORK MYSUNQUEST MYTOURS MAISON MYTRAVEL CRONOS TRAVELPLAN NETWORK INTERNATIONAL AIRFARES NEW WAY MOVING AND STORAGE NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF ANGLERS AND HUNTERS NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF HUNTERS
Gazette royale — 22 février 2012 314568 NEW BRUNSWICK FISH AND GAME ASSOCIATION 629994 New England Pizza Company 629460 NEWAY MOVING & STORAGE 629779 NIGHT SHIFT JANITORIAL 350912 Northumberland Funeral Home 351034 Old English Motorcycles 352785 Paige One Enterprises 628820 Pauley & Sons Sales Agency 623123 Pêcheries F.N. 353200 PENTARUS GRAPHICS 353279 PFC CONSULTING 629771 Phillips Security Personnel 348127 PL Digital Informatique & Satellite Enr. 629660 PORCUPINE KING 629935 POTATO INTERNATIONAL 353197 Pro-Tect Installers 629515 R & R Auto Clinic 353194 R.D.C. SPORT 629504 Randy’s Tickle Trunk 629975 RE/MAX GROUP FOUR REALTY 629613 Red Pines Art Studio 629711 Red Wave Solutions 629598 REMEMBER MONCTON OU VENIR 629858 RENT-A-MAN 350938 RICHARD BOOKKEEPING 350943 Richard Marine Sales and Service 629968 RIVER VALLEY FIRE CONSULTING 629753 Rogersville Cafe 348582 SAMUEL DOW EXPLOSIVE ORDANANCE DISPOSAL CONSULTANT 629997 Saulnier Maintenance 629679 SCHLUMBERGER ARTIFICIAL LIFT 629482 SCHLUMBERGER COMPLETIONS 629479 SCHLUMBERGER TESTING 629813 Sensabella Esthetics & Nail Studio 629967 Sevans Small Business Consulting 629714 Shear Clothing 350964 SHIRETOWN STORAGE 629901 SILI-CON LOGISTICS 629919 SILVER FERN HOLIDAYS 312336 SMITTY’S FAMILY RESTAURANT 629604 Sneek A Peek Gifts 629998 Snowbird Financial Services 351021 Soudure Gravel & Fils Enr. 629815 Steel In Time 629485 Stewart Heavy Equipment Contracting & Rentals 629881 Style & Grace Pet Salon 338034 SUCO BUSINESS SERVICES 353252 Team Air Express 353250 Team Customs Brokerage 353251 Team Ocean Services 353253 Team Worldwide 629655 The Celestrial Soul Connection 629579 The Colour Center 629850 THE GOOD GUYS BREW SHOPPE 629632 The Greens Condominium 629944 The Home Depot Supply 629609 The Mattress Medic 629947 The Primitive Cellar 312248 THE SONY STORE 629924 THN EXPLORATIONS 327956 TOUCH OF CLASS SERVICES 629824 TRACY STARR 629888 Transitions Co-Active Life Coaching 629802 Trophy Safaris Int’l New Brunswick 629547 U-Pedal Boats 629965 Valley Restaurant 629777 Vue à vol d’aigle 350931 Wavetech Business Supplies 629637 Whippowill Consulting & Sales 629844 WORLD WINE AND FOOD EXPO 629467 WWWA Wholesale
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
297
Business Corporations Act
Loi sur les corporations commerciales
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
Registered Office Bureau enregistré
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
661818 NB Ltd.
New Line
661818
2012
01
26
661821 N.B. LTD.
Saint John
661821
2012
01
26
Fine Art Collection Holdings Limited
Saint John
661830
2012
01
26
661831 N.B. Inc.
Oak Bay
661831
2012
01
27
Jean Léger & Son Contracting Inc.
McKees Mills
661832
2012
01
27
Bound Communications Inc.
Lower Woodstock
661833
2012
01
27
661836 NB LTD. 661836 NB LTEE
Perth Andover
661836
2012
01
27
Maritime Daytripping Inc.
Fredericton
661839
2012
01
27
MEGA CHAGA LTD.
Riverview
661840
2012
01
27
661841 NB LTD.
Richmond Corner
661841
2012
01
27
David Long Holdings Inc.
Rothesay
661842
2012
01
27
G.P. APARTMENTS INC.
Saint-Léonard
661843
2012
01
27
661845 N.-B. INC.
Caraquet
661845
2012
01
27
661846 NB Ltd.
Saint John
661846
2012
01
27
CAMERA CREW MEDIA PRODUCTION CORP.
Moncton
661867
2012
01
27
661868 N.B. LTD.
Grand-Sault / Grand Falls
661868
2012
01
28
Timoe Express Inc.
Bouctouche
661869
2012
01
29
ElectroCore Canada, Inc.
Saint John
661870
2012
01
30
661871 N.-B. CORP.
Moncton
661871
2012
01
30
Northern Highlights Hair & Body Salon Ltd.
Fredericton
661872
2012
01
30
KSK Holdings Inc.
Moncton
661874
2012
01
30
Dent Pro Hail Repair Inc.
Riverview
661880
2012
01
30
ROYAL ATLANTIC OYSTER INC.
Saint-Louis
661881
2012
01
30
Saint John Early Childhood Centre Ltd.
Saint John
661883
2012
01
30
TOBIQUE FARMS OPERATING (2012) LIMITED
DSL de / LSD of Drummond
661889
2012
01
30
Fortin Construction (2012) Inc.
Grand-Barachois
661891
2012
01
30
EXHALE YOGA BOUTIQUE INC.
Campbellton
661892
2012
01
30
MSP Work Solutions Inc. / Solutions au travail MSP Inc.
Moncton
661893
2012
01
30
MDS IGLASS INC.
Moncton
661894
2012
01
30
K&W ENTERPRISES LTD.
Apohaqui
661903
2012
01
31
Name / Raison sociale
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
298
C. Scott Holdings Ltd.
Saint John
661908
2012
01
31
661913 NB Inc.
Moncton
661913
2012
01
31
TEC Encryption Technology Ltd.
Shediac
661918
2012
01
31
Three Talons Investigations Ltd.
Saint John
661921
2012
01
31
FREDDIE’S PIZZA LTD.
Moncton
661923
2012
01
31
Sugarloaf Estates Inc.
Moncton
661924
2012
01
31
Ryan Oak Estates Inc.
Moncton
661927
2012
02
01
661928 N.B. INC.
Riverview
661928
2012
02
01
DR. BRETT TREMBLE PROFESSIONAL CORPORATION
Moncton
661929
2012
02
01
Coast Tire (Summerside) Ltd.
Saint John
661939
2012
02
01
Brian Morin Construction Inc.
Edmundston
661941
2012
02
01
Carter’s Cranberries Inc.
Central Blissville
661942
2012
02
01
Chantal’s Steakhouse Inc.
Saint-Joseph
661950
2012
02
02
Burke & Theriault Investments Ltd.
Fredericton
661955
2012
02
02
TONA Holdings Ltd.
Island View
661956
2012
02
02
MP Investments Corp.
Island View
661957
2012
02
02
661958 N.B. Ltd.
New Denmark
661958
2012
02
02
Gold Bar Development & Consulting Inc.
Shediac
661965
2012
02
02
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à :
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
Previous Jurisdiction Compétence antérieure
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
661047 N.B. Inc.
Saint John
Canada
661047
2012 01
31
661048 N.B. Inc.
Saint John
Canada
661048
2012 01
31
661046 N.B. Inc.
Saint John
Canada
661808
2012 01
31
GREEN HAVEN MOBILE HOMES LIMITED
Saint John
Ontario
661811
2012 01
31
COWAN PLACE LIMITED
Saint John
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia
661812
2012 01
31
VOGUE HOLDINGS INC.
Saint John
Île-du-Prince-Édouard / 661930 Prince Edward Island
2012 01
31
_____________________________________________________
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
299
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à :
Name / Raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
GUIDOU ELECTRIC LTD.
007580
2012 01
31
J. L. SIMMS (’74) LTD.
015203
2012 01
30
CAJO MARTEL TRANSPORT LIMITEE
020201
2012 01
27
CLEARWATER WELL DRILLING (1983) LTD.
031695
2012 01
31
WALCOTT MACHINING AND FABRICATION LTD.
059792
2012 01
31
Fermes Semences Desjardins Seed Farms Ltd./Ltée
512472
2012 01
27
LITECO INC.
513882
2012 01
31
HARD ROCK DRILLING LTD.
606390
2012 01
27
I. GÉRALD LÉVESQUE CORPORATION PROFESSIONNELLE / I. GÉRALD LÉVESQUE PROFESSIONAL CORPORATION
608311
2012 01
31
635116 N.B. LTD.
635116
2012 01
31
JAKAS Holdings Inc.
635117
2012 01
31
SwiftRadius Inc.
635872
2012 01
31
BREWCO PLANNING INC.
642006
2012 02
01
661378 N.B. Ltd.
661378
2012 02
01
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à :
Name / Raison sociale
Previous name Ancienne raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
QPS Canada Inc.
Interactive Visualization Systems, Inc.
608306
2012 01
26
608667 NB Inc.
EAST SIDE SPORTS INC.
608667
2012 01
26
CHARLES STREET FINANCIAL INC.
Son Communications Inc.
617213
2012 01
31
Productions Siallam Inc.
644931 N.-B. Ltée
644931
2012 01
31
Phytoplankton Biotech Inc.
Sackville Jam Shack Ltd.
653307
2012 01
31
654744 N.-B. INC.
654744 N.-B. INC.
654744
2012 01
31
Tri-Star Antimony Canada Inc.
656952 N.B. Inc.
656952
2012 01
27
658785 N.B. Inc.
Maritime Fastening Systems (2011) Inc.
658785
2012 01
30
X & O HOLDINGS LTD.
659780 NB INC.
659780
2012 01
31
Westmorland Animal Hospital Inc.
660908 NB Inc.
660908
2012 01
25
_____________________________________________________
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
300
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à :
Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion
Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes
Registered Office Bureau enregistré
Reference Number Numéro de référence
L.M.D. Holdings Ltd.
L.M.D. HOLDINGS LTD. 630921 N.B. Ltd.
Moncton
661715
2012 01
31
Stewie’s Lobsters Ltd.
CHAOS FISHERIES LTD. STEWIE’S LOBSTERS LTD.
Alma
661779
2012 01
31
660551 NB LTD.
055720 N.B. LTD. 660551 NB LTD.
Bath
661855
2012 02
01
LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.
CORLAND CONSTRUCTION INC. LANCOR CONCRETE CONTRACTORS LTD.
Dieppe
661859
2012 02
01
Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD A. BOLDUC, M.D., C.S.P.Q., Dermatolgue Inc. F.R.C.P.(C),C.P. Inc. Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD Dermatologue Inc.
Moncton
661877
2012 02
01
628377 NB INC.
628377 NB INC. 658580 NB LTD.
Fredericton
661905
2012 02
01
Liteco Inc.
SJK HOLDINGS LTD. LITECO INC. R.G.M. INVESTMENTS (2006) INC.
Fredericton
661914
2012 02
01
049046 N.B. Ltd.
049046 N.B. LTD. CHIGNECTO ENTERPRISES LIMITED LONAMY INC.
Upper Coverdale
661916
2012 02
01
Belmar Investments Limited
Mejora Holdings Limited Belmar Investments Limited
Woodstock
661945
2012 02
01
Date Year Month Day année mois jour
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à :
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
GARAGE ST. PIERRE LTEE
Kedgwick
006928
2012
01
19
NORTH SHORE ALARMS-HUDON’S SECURITY SERVICES CO. LTD.
Bathurst
032714
2012
01
30
Cebacob Holdings Ltd.
Bocabec
033407
2012
01
26
CHARLES E. WILLIAMS & COMPANY LTD
Grand Bay-Westfield
047441
2012
01
20
ENTREPRISE S.K. (1993) LTEE
Kedgwick
053507
2012
01
19
SLEDS & TREADS LTD.
Sussex
500742
2012
01
27
JOE’S WOODWORKING LTD.
Fredericton
504033
2012
01
31
MOUNT MISERY HOLDINGS INC.
Kingston
506518
2012
01
26
Anacomp Canada Inc.
Saint John
604923
2012
01
25
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
301
MHR HOLDING INC.
Moncton
606039
2012
01
30
The Davis & Lee Financial Planning Centre Ltd.
Rothesay
610535
2012
01
10
Kindred Sound Productions Inc
Saint John
610814
2012
01
25
JD Vending Inc.
Dieppe
622448
2012
01
26
Executive Auto Imports Ltd.
Fredericton
633720
2012
01
26
Accurate Tax & Accounting Inc.
Saint John
636674
2012
01
19
Lemon Chiffon Ventures Limited
Saint John
638369
2012
01
19
Cogwheel Properties Limited
Saint John
643063
2012
01
25
Charlie’s Trucking Inc.
Saint-Charles
644139
2012
01
27
Braeside Solar Park 2 GP Inc.
Saint John
653731
2012
01
23
MSD E-Commerce Solutions Ltd.
Belleville
655032
2012
01
19
Cusack Real Property Consulting Ltd.
Saint John
655248
2012
01
18
Canatara Solar 1 GP Inc.
Saint John
657785
2012
01
23
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, notice of the discharge of a receiver or a receivermanager of the following corporations has been received:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un avis de libération d’un séquestre ou séquestre-gérant pour les sociétés suivantes a été reçu :
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
Receiver or Receiver-Manager Séquestre ou séquestre-gérant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Deer Island Salmon Ltd.
Lords Cove
Ernst & Young Inc.
053503
2012
02
02
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to:
Name / Raison sociale
Scandinavian Tobacco Group Canada Inc./ Groupe Tabac Scandinave Canada Inc.
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de cessation a été émis à :
Jurisdiction of Continuance Compétence de prorogation
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Québec / Quebec
661314
2012 01
16
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à :
Name / Raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
O’BRIEN & LANDRY LIMITED
012504
2012 01
26
J.M. & C.W. HOPE GRANT LTD.
038664
2012 01
26
DUNCAN HOLDINGS LTD.
057091
2012 01
26
T & L Electrical Ltd.
615744
2012 01
26
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
302
WENDY SERGEANT GENERAL CLEANING LTD.
620737
2012 01
27
Wards Creek Holdings Ltd.
634847
2012 01
26
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Jurisdiction Compétence
Agent and Address Représentant et adresse
VANGUARD INVESTMENTS CANADA INC. PLACEMENTS VANGUARD CANADA INC.
Canada
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661605
2012 01
17
Specialty Risk Underwriters Inc.
Canada
David Bruce Cannon Irishtown
661616
2012 01
17
Product Remanufacturing Centers Canada, Canada Limited Centres de Remise à Neuf de Produits Canada, Limitée
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661626
2012 01
18
P.S. Atlantic Limited
Struan Smith Moncton
661666
2012 01
19
Ontario XEROX FINANCIAL SERVICES CANADA LTD./SERVICES FINANCIERS XEROX CANADA LTEE.
William T. Walker Fredericton
661705
2012 01
20
Affordable Plumbing & Mechanical Inc.
Ontario
Alison J. Harvey Haut-Sheila
661750
2012 01
24
ASPHALTE BAS-ST-LAURENT INC.
Canada
Daniel Bélanger Grand-Sault / Grand Falls
661751
2012 01
24
Bouclair Inc.
Québec / Quebec
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661776
2012 01
25
Wingenback Inc.
Alberta
Sheryl D. Tabor Sussex
661777
2012 01
25
Bruns-Pak Worldwide, Inc.
New Jersey
Steven D. Christie Fredericton
661792
2012 01
25
FRONTLINE RAILCAR REPAIR LTD.
Saskatchewan
John B. Malone Sussex
661853
2012 01
27
Provident Agency, Inc.
Canada
Craig A. Sampson Moncton
661854
2012 01
27
ASSURANCES NORMAN MCCANN INC.
Québec / Quebec
Norman McCann Caraquet
661873
2012 01
30
Tundra Consulting Inc.
Nunavut
R. Gary Faloon Saint John
661885
2012 01
30
Name / Raison sociale
Terre-Neuve et Labrador/ Newfoundland and Labrador
_____________________________________________________
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
303
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à :
Previous name Ancienne raison sociale
Name / Raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
AZGA Insurance Agency Canada Ltd.
WORLD ACCESS INSURANCE BROKERS LTD.
600874
2012 01
27
326551 Canada Inc.
Bodkin Leasing Corporation
612286
2012 01
18
3267911 Canada Inc.
Bodkin Capital Corporation
612287
2012 01
18
IKON Office Solutions ULC
IKON OFFICE SOLUTIONS, INC./ IKON SOLUTIONS DE BUREAU, INC.
615949
2012 01
23
AZGA Service Canada Inc.
World Access Canada Inc.
639363
2012 01
27
Dynamitage Castonguay ltée / Castonguay Blasting Ltd.
DNX Castonguay Inc.
648699
2012 01
23
Atos IT Solutions and Services Inc./ Atos Solutions et services en TI inc.
Siemens IT Solutions and Services Inc./ Siemens Solutions et services en TI Inc.
651618
2012 01
31
Skyline Wealth Management Inc.
Skyline Asset Management Inc.
653234
2012 01
24
FGL Sports Ltd. FGL Sports Ltee
FGL AcquisitionCo Limited
661807
2012 01
26
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations:
Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion
Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Représentant et adresse
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
EXTENDICARE (CANADA) INC. EXTENDICARE (CANADA) INC.
Steven Christie Fredericton
661088
2012
01
19
Siemens Canada Limited/ Siemens Canada Limited
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC LTD. SIEMENS DIAGNOSTICS EN SOINS DE SANTÉ LTÉE SIEMENS CANADA LIMITED / SIEMENS CANADA LTÉE
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661684
2012
01
20
NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE
Stewart McKelvey NEBS PAYROLL SERVICE Corporate Services (NB) Inc. LIMITED Saint John NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE
661685
2012
01
20
KODAK CANADA INC.
KODAK CANADA INC.
George L. Cooper Moncton
661701
2012
01
20
Cliffs Chromite Ontario Inc.
Cliffs Chromite Ontario Inc.
George L. Cooper Moncton
661702
2012
01
20
MGA PARTNERS INC.
Blonde & Little Financial Services Ltd Terry Fitzgerald Fredericton
661712
2012
01
20
Ricoh Canada Inc.
IKON Office Solutions ULC Ricoh Canada Inc.
661741
2012
01
23
Bernard F. Miller Moncton
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
304
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Human Resource Capital Group Inc. Stewart McKelvey Groupe Capital de Ressource Humaine Corporate Services (NB) Inc. Saint John Inc. Randstad Intérim Inc./Randstad Interim Inc.
661744
2012
01
24
JIM PEPLINSKI LEASING INC.
JIM PEPLINSKI’S AUTO LEASING Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. LTD. Saint John HUMBERVIEW MOTORS INCORPORATED
661771
2012
01
25
Homewood Human Solutions Canada Inc.
Homewood Human Solutions Canada Stewart McKelvey Inc. Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661775
2012
01
25
The Forzani Group Ltd.
SPORTS EXPERTS 2000 INC. THE FORZANI GROUP LTD. Sport-Chek International 2000 Ltd.
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661806
2012
01
26
FGL AcquisitionCo Limited
The Forzani Group Ltd.
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661807
2012
01
26
LAFARGE CANADA INC.
LAFARGE CANADA INC.
Alex Kennedy Moncton
661856
2012
01
27
Element Financial Corporation
ELEMENT FINANCIAL CORPORATION
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661861
2012
01
27
Hazmasters Inc.
Hazmasters Inc.
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661862
2012
01
27
Companies Act
Loi sur les compagnies
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes ont été émises à :
Name / Raison sociale
Head Office Siège social
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
LES BRAYONS MASQUÉS INC.
Edmundston
661784
2012 01
25
HAITI VILLAGE HEALTH INC.
Miramichi
661847
2012 01
27
CHILD CARE OWNERS’ & OPERATORS OF SOUTHERN NEW BRUNSWICK INC.
Saint John
661906
2012 01
31
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act, supplementary letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres patentes supplémentaires ont été émises à :
Name / Raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
MULTICULTURAL ASSOCIATION OF FREDERICTON INC.
011467
2012
_____________________________________________________
01
27
The Royal Gazette — February 22, 2012
PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the following company is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:
Gazette royale — 22 février 2012
305
SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituée en vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :
Name / Raison sociale
MEMRAMCOOK VOLUNTEER FIREMEN’S ASSOC. INC. L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE MEMRAMCOOK INC.
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
010863
2012 01
27
Partnerships and Business Names Registration Act
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Certificate Enregistreur du certificat
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
NORTH SHORE CINEMA
633970 N.B. Limited
Campbellton
661172
2012 01
26
Tradewinds Truck Service
Scoudouc Truck Service Inc.
Shediac
661492
2012 01
23
Bay of Fundy Adventures
630227 N.B. INC.
Rothesay
661613
2012 01
17
Kane Construction
630227 N.B. INC.
Rothesay
661614
2012 01
17
GOLD BUYERS NEW BRUNSWICK Mark Rzepka
Saint John
661625
2012 01
18
Fairvale Physiotherapy Clinic
PT Health NB Professional Corporation
Rothesay
661639
2012 01
18
River Valley Ventilation & Heating
Luke Dukeshire
Northampton
661662
2012 01
27
Stever-Ryu Jujutsu
Nathan Stever
Big River
661664
2012 01
19
SWIT SWOO SERVICES
Harvey A. Hillis
Florenceville-Bristol
661669
2012 02
01
Agence basKASTing Agency
Julie Basque
Tracadie-Sheila
661671
2012 01
31
Buanderie Dieppe Laundry
659298 NB INC.
Dieppe
661697
2012 01
20
TARGET
TARGET CANADA CO.
Saint John
661717
2012 01
23
TARGET CANADA
TARGET CANADA CO.
Saint John
661718
2012 01
23
MAISONS LEVESQUE
GÉRANCE DE PROJET RÉSIDENTIEL
Dieppe
661724
2012 01
23
KANE HOMES
630227 N.B. INC.
Rothesay
661729
2012 01
23
Salon Milady
Denise Lanteigne
Caraquet
661730
2012 01
23
The General Store St. Andrews
659761 N.B. INC.
Saint Andrews
661734
2012 01
27
Kevin Dinsmore Painting
Kevin Dinsmore
Pomeroy Ridge
661739
2012 01
23
VETEMENTS O BON PRIX ENR.
CHEZ ROBICHAUD LTEE
Shippagan
661752
2012 01
24
Name / Raison sociale
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
306
KV VINEYARD
KENNEBECASIS VALLEY VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP INC.
Quispamsis
661763
2012 01
24
TEAM BESLER
MGI SECURITIES INC.
Saint John
661778
2012 01
25
Moncton Kiwanis Basketball Association
MONCTON MINOR BASKETBALL ASSOCIATION, Inc.
Moncton
661780
2012 01
25
New Brunswick Northern Railway Company
NEW BRUNSWICK SOUTHERN Saint John RAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAUBRUNSWICK LIMITEE
661785
2012 01
25
NB Northern
NEW BRUNSWICK SOUTHERN Saint John RAILWAY COMPANY LIMITED/ LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU SUD, NOUVEAUBRUNSWICK LIMITEE
661787
2012 01
25
Raduga Market
Gelena Devedjinejad
Moncton
661788
2012 01
25
Modern Hüs
Jon-Matthew O’Hara
Moncton
661815
2012 01
26
KING PERFORMANCE
Gordon King
Fredericton
661816
2012 01
26
DUKE CREATIVE COLLECTIVE
Elizabeth Richardson
Saint John
661825
2012 01
26
SAILBLOG.NET
Michael Taylor
Saint John
661834
2012 01
27
Centre de conditionnement ÉducACTION (Edmundston)
Mike Couturier
Edmundston
661837
2012 01
27
FACE-IT GENEVIÈVE
Geneviève Albert
Moncton
661838
2012 01
27
Hubert Williston Renovations and Construction
Hubert Williston
Napan
661844
2012 01
27
MCGUIRE REHAB RENOS
MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.
Saint John
661848
2012 01
27
MCGUIRE’S TRINKETS & TREASURES
MCGUIRE PROPERTY MANAGEMENT LTD.
Saint John
661849
2012 01
27
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
AZGA Insurance Agency Canada Ltd.
Saint John
661857
2012 01
27
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
AZGA Service Canada Inc.
Saint John
661858
2012 01
27
SNACKMAN VENDING SERVICES Chris Morrison
Moncton
661865
2012 01
27
Sussex Ventilation & Heating
Gordon Keddy
Sussex
661875
2012 01
30
Yellowline Vending
Tim Rose
Moncton
661878
2012 01
30
VÂN’s NAILS
BichVan Tuthi
Bathurst
661879
2012 01
30
Progress at Home Physiotherapy
Natalie Ann Brand Russell
Quispamsis
661888
2012 01
30
RRNJ Style Sales
Roxanne Maillet
Moncton
661890
2012 01
30
Chris Parks Trucking
Chris Parks
Moncton
661895
2012 01
31
JOE’S WOODWORKING
Joe Pitre
Fredericton
661900
2012 01
31
Sunset Realty Group
David Boucher
Dieppe
661901
2012 01
31
R. Nason Renovations
Rick Nason
Geary
661904
2012 01
31
ADRIAN FORGIE BUILDER CONTRACTOR
Adrian Forgie
Rothesay
661910
2012 01
31
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
307
JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS Dwight Cummings SOLUTIONS
Saint John
661911
2012 01
31
MR HANDYMAN BY SERGE
Serge Ethier
Saint John
661912
2012 01
31
LAURA COMEAU ART
Laura Lea Wergin Comeau
Derby
661917
2012 01
31
Barachois Vehicle Import Personal Auto Sales
John MacNeill
Grand-Barachois
661919
2012 01
31
S. Macphee Auto Salvage
Scott Macphee
Petitcodiac
661920
2012 01
31
FK MotoTech
Francis Séguin
Oromocto
661922
2012 01
31
NINE-DOT MARKETING
Christopher Bastarache
Moncton
661925
2012 02
01
Sweetstix Treats
Adrianna Stevens
Moncton
661926
2012 02
01
NLB Nuclear Process Services
Normand L. Boucher, P.Eng
Saint John
661935
2012 02
01
Phil’s Automation Industrial Control Systems
Philip Kilpatrick
Picadilly
661938
2012 02
01
BDLAW
Brent A. Dickinson
Woodstock
661940
2012 02
01
Exclusive Events
Jennifer Mae Rose
Oromocto
661943
2012 02
01
Natures Pet Spa
Jennifer Stenzler
Dieppe
661966
2012 02
02
NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUM Partnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales In relation to the certificate of business name registered on January 18, 2012 under the Act, under the name of “Fundy Flair For Hair”, being file #661648, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the name of the person in section 3 of form 5 be corrected to read as follows “Tammie Wyttner”. Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 18 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « Fundy Flair For Hair », dont le numéro d’appellation commerciale est 661648, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que le nom de la personne indiquée à la section 3 du formulaire 5 soit corrigé pour qu’il se lise comme suit : « Tammie Wyttner ». _____________________________________________________ In relation to the certificate of business name registered on January 31, 2012 under the Act, under the name of “JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS”, being file #661911, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name be corrected to read as follows: “JPS SIGNS AND IDENTIFICATION SOLUTIONS”. Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 31 janvier 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « JPS SIGNS AND IDENTIFICATIONS SOLUTIONS », dont le numéro d’appellation commerciale est 661911, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que l’appellation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « JPS SIGNS AND IDENTIFICATION SOLUTIONS ». _____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Name / Raison sociale
Registrant of Certificate Enregistreur du certificat
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
VERNON BISHOP TOWING
Vernon Bishop
Chipman
321834
2012 01
26
LITECO
Liteco Inc.
Fredericton
323853
2012 02
01
LA ROMA MOTEL ENRG.
058429 N.B. INC.
Saint-Basile
335005
2012 01
26
CNC GLOBAL SEARCH
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
346054
2012 01
24
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
308
CNC GLOBAL CONSULTING
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
346055
2012 01
24
B.A.S.A. RÉPARATIONS & SERVICES
Frederic Savoie
Balmoral
350623
2012 01
30
McKINNON EXCAV.
Mark A. McKinnon
Quispamsis
350784
2012 01
26
LITETEC
Liteco Inc.
Fredericton
351058
2012 02
01
CCS - Complete Computer Service
Frank David MacNeil
New Maryland
353277
2012 01
31
WESTFIELD BEACH ENTERPRISES
Avril Wood-Toner
Grand Bay-Westfield
353304
2012 01
27
The DFS Group
NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE
Saint John
603935
2012 01
20
POWER DAWG
Liteco Inc.
Fredericton
605858
2012 02
01
SPHERION
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
615659
2012 01
24
Altron Color Imaging
Kevin Frenette
Moncton
628922
2012 01
28
CLINIQUE TENDANCE SANTÉ NATHALIE
Nathalie Noel-Doiron Hazel McMullin
Shippagan
629048
2012 01
26
Le Bon Sang
Denise Gallant
Bouctouche
629225
2012 01
28
Countertop Creations
COUNTERTOPS PLUS LTD.
Moncton
629261
2012 01
24
Blaney Cycle Supply
Barry Blaney
Nortondale
629387
2012 01
26
John Maunder Insurance
Capital Insurance Services Ltd.
Fredericton
630849
2012 01
25
DFS Business Forms
NEBS BUSINESS PRODUCTS LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRES NEBS LIMITEE
Saint John
635532
2012 01
20
TODAYS STAFFING
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
636207
2012 01
24
Sapphire Global Services
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
643769
2012 01
24
Silver Group Purchasing
EXTENDICARE (CANADA) INC.
Fredericton
650621
2012 01
19
CANADA’S CAR MART
OLeary Buick GMC (Saint John Ltd.)
Saint John
651033
2012 01
24
Randstad Technologies
Randstad Intérim Inc. / Randstad Interim Inc.
Saint John
658060
2012 01
24
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré : Address / Adresse
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
FAIRVALE PHYSIOTHERAPY CLINIC
Rothesay
335391
2012
01
18
JIM PEPLINSKI’S LEASEMASTER NATIONAL
Saint John
349576
2012
01
25
Name / Raison sociale
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
309
Jean Léger & Son Contracting
McKees Mills
607999
2012
01
27
LAID BACK PUB
Grand-Sault / Grand Falls
608391
2012
02
01
Wendy Sergeant General Cleaning
Bathurst
610451
2012
01
27
FREDDIE’S PIZZA
Moncton
618158
2012
01
31
DOMAINE DU RUISSEAU
Dieppe
636511
2012
01
31
Mondial Assistance
Saint John
638804
2012
01
27
Mondial Assistance
Saint John
639364
2012
01
27
MSP Work Solutions / Solutions au travail MSP
Dieppe
654282
2012
01
30
Tradewinds Truck Service
Shediac
658443
2012
01
23
Pet Grooming by Jennifer
Dieppe
658890
2012
02
02
Xylem Residential & Commercial Water
Saint John
661457
2012
01
31
Xylem Water Solutions
Saint John
661458
2012
01
31
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for service has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :
Agent and Address / Représentant et adresse
Name / Raison sociale
ROBERT BURY & COMPANY (CANADA)
Don Poley Moncton
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
628641
2012
01
24
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered:
Name / Raison sociale
Partners / Membres
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
HIGHLITE HAIR SALON
Kevin Russell William Russell
Miramichi
661540
2012
01
27
Hilton Spring Farm
Ruby Spencer Brian Spencer
Parker Ridge
661617
2012
01
17
Frufrus “Asian skin care and beauty products”
Jerome Janson Ong Djoana Marie Wasson
Fredericton
661672
2012
01
19
Rowan McGrath Lawyers
Donald Rowan Law Professional Corporation Elizabeth Mary McGrath
Fredericton
661686
2012
01
20
HARBOUR CENTRE
John Lawson Don Sterritt
Saint John
661727
2012
01
23
KALIE’S BUTTERFLIES
Marie Ann Harrison Jena Lynn Beauchamp
Gagetown
661764
2012
01
24
_____________________________________________________
The Royal Gazette — February 22, 2012 PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of firm name has been registered:
Name / Raison sociale
Soucy Richard
Gazette royale — 22 février 2012
310
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement de raison sociale a été enregistré :
Previous Name Ancienne raison sociale
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Soucy Richard Godbout Wallace
Dieppe
625392
2012
02
01
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of partnership has been registered:
Name / Raison sociale
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement de société en nom collectif a été enregistré :
Partners / Membres
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Soucy Richard
Pierre S. Soucy Marc-André Richard
Dieppe
625392
2012
02
01
Resto Ma-Gi-Co
Gisele Boudreau Marie-May Boudreau
Shediac
629047
2012
01
24
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré : Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Retiring Partners Associés sortants
Incoming Partners Nouveaux associés
Spacek & Associates Chartered Accountants
Bruce Lunergan Professional Corporation
Nick Norrad Professional Corporation
345806
2011
12
28
Shell Canada Upstream
Duvernay Oil Corp.
Shell Canada Limited
641663
2012
01
25
Name / Raison sociale
Limited Partnership Act
Loi sur les sociétés en commandite
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par :
Name / Raison sociale
Matrix 2012 - I National and Quebec Resource Flow Through LP
Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick
Jurisdiction Compétence
Saint John
Ontario
Agent and Address Représentant et adresse
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
661627
2012
01
18
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
311
HETTICH CANADA LIMITED PARTNERSHIP
Moncton
Ontario
Bob Vautour Moncton
661670
2012
01
19
Sprott 2012 Flow-Through Limited Partnership
Saint John
Ontario
Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc. Saint John
661716
2012
01
23
QWEST 2012 OIL & GAS FLOWTHROUGH LIMITED PARTNERSHIP
Saint John
Stewart McKelvey ColombieCorporate Services Britannique / British Columbia (NB) Inc. Saint John
661743
2012
01
24
Department of Environment
Ministère de l’Environnement
NOTICE UNDER THE COMMUNITY PLANNING ACT PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under the Community Planning Act, subsection 77(2.96), Ministerial Regulation for the Chamcook Planning Area under the Community Planning Act, being Ministerial Regulation 11-CHA-036-00, otherwise cited as the Chamcook Planning Area Rural Plan Regulation - Community Planning Act, was enacted by the Minister of Environment on January 16, 2012 and filed in the Charlotte County Registry office on January 24, 2012 under official number 31089155.
AVIS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR L’URBANISME AVIS PUBLIC EST DONNÉ, PAR LES PRÉSENTES, conformément au paragraphe 77(2.96) de la Loi sur l’urbanisme, qu’un règlement ministériel pour du secteur d’aménagement de Chamcook, établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme, soit le Règlement ministériel 11-CHA-036-00, autrement cité comme le Règlement établissant le plan rural du secteur d’aménagement de Chamcook - Loi sur l’urbanisme, a été adopté par la ministre de l’Environnement le 16 janvier 2012 et a été déposé au bureau d’enregistrement du comté de Charlotte le 24 janvier 2012 sous le numéro 31089155.
Department of Justice and Consumer Affairs
Ministère de la Justice et de la Consommation
Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, chapter C-32.2, that the Caisse populaire Sud-Est Ltée has amended its articles effective December 23, 2011.
Sachez, en vertu du sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2, que la Caisse populaire Sud-Est Ltée a modifié ses statuts en date du 23 décembre 2011.
Pierre LeBlanc, CA Superintendent of Credit Unions
Le surintendant des caisses populaires Pierre LeBlanc, c.a.
________________
________________
Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) of the Credit Unions Act, Chapter C-32.2, that La Caisse Populaire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaire Kent-Centre Ltée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caisse populaire Kent-Sud Ltée, and Caisse populaire Sud-Est Ltée have amalgamated effective the 1st day of January, 2012 under the name Caisse populaire Sud-Est Ltée and that the provisions of the Credit Unions Act have been complied with.
Sachez que, conformément au sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2, La Caisse Populaire de Baie Ste. Anne Ltée, Caisse populaire Kent-Centre Ltée, Caisse populaire Kent Nord Ltée, Caisse populaire KentSud Ltée, et Caisse populaire Sud-Est Ltée ont fusionné pour devenir à compter du 1 janvier 2012 Caisse populaire Sud-Est Ltée et que toutes les dispositions de la Loi sur les caisses populaires ont été respectées.
Pierre LeBlanc, CA Superintendent of Credit Unions
Le surintendant des caisses populaires Pierre LeBlanc, c.a.
The Royal Gazette — February 22, 2012
312
Gazette royale — 22 février 2012
New Brunswick Securities Commission
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
REQUEST FOR COMMENTS Notice and Request for Comment – Publishing for comments:
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis de consultation et demande de commentaires – Publication en vue de recueillir des commentaires sur : • le projet de la Norme multilatérale 32-102 sur les dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents (NM 32-102); • le projet de l’Instruction complémentaire 32-102IC (32-102IC); et • les modifications corrélatives proposées à l’Instruction complémentaire 31-103IC relative à la Norme canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (31-103IC) (collectivement, les textes proposés).
• proposed Multilateral Instrument 32-102 Registration Exemptions for Non-Resident Investment Fund Managers (MI 32-102); • proposed Companion Policy 32-102CP (32-102CP); and • proposed consequential amendments to Companion Policy 31-103CP Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (31-103CP) (together, the Proposed Materials). Introduction On January 23rd, 2012, the New Brunswick Securities Commission (Commission) approved publication in order to obtain comments on the Proposed Materials.
Introduction Le 23 janvier 2012, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (Commission) a autorisé la publication en vue de recueillir des commentaires sur les textes proposés.
Summary of Proposed Materials MI 32-102 and 32-102CP would apply in Ontario, Québec, New Brunswick and Newfoundland and Labrador (the jurisdictions) and relate to proposed registration exemptions for investment fund managers that do not have their head office or their principal place of business in a jurisdiction of Canada and that do not have a place of business in the local jurisdiction (nonresident investment fund managers).
Résumé des textes proposés NM 32-102 et 32-102IC s’appliqueraient en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les territoires) et établiraient des dispenses d’inscription pour les gestionnaires de fonds d’investissement qui n’ont pas leur siège ou leur établissement principal situé dans un territoire du Canada et qui n’ont pas d’établissement dans le territoire intéressé (les gestionnaires de fonds d’investissement nonrésidents). La règle proposée dispenserait les gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents de l’obligation de s’inscrire dans les territoires lorsqu’il n’y a pas de facteur de rattachement significatif avec le territoire intéressé. NM 32-102 prévoit une dispense de l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement dans le cas où il n’y a aucun porteur du fonds d’investissement ou démarchage actif de résidents dans le territoire intéressé. 32-102IC fournit des indications sur ce qui serait considéré ou non comme du démarchage actif. La règle proposée prévoit également une dispense dans le cas où le placement des titres du fonds au Canada se serait limité à des clients autorisés Le but de la modification corrélative de l’article 7.3 de 31-103IC est de renvoyer les lecteurs aux indications concernant l’obligation d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents.
MI 32-102 would exempt non-resident investment fund managers from the requirement to register in the jurisdictions in circumstances where there are no significant connecting factors to the local jurisdiction. The Proposed Materials include an exemption from the investment fund manager registration in circumstances where there are no security holders of the investment fund, or active solicitation of residents, in the local jurisdiction. 32-102CP provides guidance on what would and would not be considered active solicitation. The proposed rule also provides an exemption in circumstances where the Canadian distribution of the fund’s securities would be restricted to permitted clients. The purpose of the proposed consequential amendment to section 7.3 of 31-103CP is to provide references to applicable guidance on the registration requirement for non-resident investment fund managers. Request for Comment The Commission welcomes your comments on the Proposed Materials as they apply to New Brunswick only.
Demande de commentaires La Commission désire prendre connaissance de vos commentaires au sujet des textes proposés mais uniquement dans la mesure où cela s’applique au Nouveau-Brunswick.
The Royal Gazette — February 22, 2012
How to Obtain a Copy and Provide your Comments The text of the Proposed Materials as well as a more detailed notice can be obtained from the Commission website at: www.nbsc-cvmnb.ca.
313
Gazette royale — 22 février 2012
Pour prendre connaissance des documents et nous faire part de vos commentaires On trouvera les documents énoncés ci-dessus ainsi qu’un avis plus détaillé par l’entremise du site web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca.
A paper copy of the Proposed Materials may be obtained by writing, telephoning or e-mailing the Commission. Comments are to be provided, in writing, by no later than April 10th, 2012, to:
On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission. Veuillez nous faire part de vos commentaires par écrit au plus tard le 10 avril 2012 à l’adresse suivante :
Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within N.B. only) Fax: 506-658-3059 E-mail:
[email protected]
Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel :
[email protected]
We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires that a summary of the written comments received during the comment period be published.
Nous sommes incapables de garantir la confidentialité des commentaires formulés, étant donné que les mesures législatives sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent que soit publié un résumé des observations écrites qui sont reçues au cours de la période de consultation.
Questions If you have any questions, please refer them to:
Questions Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :
Kevin Hoyt Director, Regulatory Affairs New Brunswick Securities Commission Tel: 506-643-7691 Email:
[email protected]
Kevin Hoyt Directeur des affaires réglementaires Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick Téléphone : 506-643-7691 Courriel :
[email protected]
Notices of Sale
Avis de vente
TO: FLOYD JOSEPH GALLANT AND MARIE NORMA GALLANT, Mortgagors; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 10 Hamilton Beach Road, Charlo, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 50068675. Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINION BANK. The sale is scheduled for Thursday, March 22, 2012, at 11:00 a.m., at the Campbellton Court House, 157 Water Street, Campbellton, New Brunswick.
DESTINATAIRES : FLOYD JOSEPH GALLANT ET MARIE NORMA GALLANT, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 10, chemin Hamilton Beach, Charlo, province du Nouveau-Brunswick, et ayant le numéro d’identification parcellaire 50068675. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le jeudi 22 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Campbellton, 157, rue Water, Campbellton (Nouveau-Brunswick).
The Royal Gazette — February 22, 2012
314
Gazette royale — 22 février 2012
See advertisements in The Tribune in the issues of February 24, March 2, March 9 and March 16, 2012.
Voir l’annonce publiée dans les éditions du 24 février et des 2, 9 et 16 mars 2012 du Tribune.
THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)
Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust)
________________
________________
TO: RÉJEAN GEORGE COMEAU AND SOPHIE ROY, Mortgagors; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 203 Marie Street, Beresford, in the County of Gloucester, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 20774998. Notice of Sale is given by THE TORONTO-DOMINION BANK. The sale is scheduled for Wednesday, March 21, 2012, at 11:00 a.m., at the Bathurst Court House, 254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. See advertisements in The Northern Light, in the issues of February 21, February 28, March 6 and March 13, 2012. DATED this 25th day of January, 2012.
DESTINATAIRES : RÉJEAN GEORGE COMEAU ET SOPHIE ROY, débiteurs hypothécaires; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 203, rue Marie, Beresford, comté de Gloucester, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 20774998. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le mercredi 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 21 et 28 février et des 6 et 13 mars 2012 du Northern Light. FAIT le 25 janvier 2012.
THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: ROBERT M. CREAMER, Solicitors for THE TORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)
ROBERT M. CREAMER, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de LA BANQUE TORONTODOMINION (TD Canada Trust)
________________
________________
Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Darren Robert Hanselpacker and Julie Marie Hanselpacker, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 96 Brunswick Street, St. George, New Brunswick, the same lot conveyed to Darren Robert Hanselpacker and Julie Marie Hanselpacker by Deed registered in the Charlotte County Registry Office on October 22nd, 1999, in Book 703, Pages 355-358, as document number 10572619.
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Darren Robert Hanselpacker et Julie Marie Hanselpacker, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 96, rue Brunswick, St. George (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Darren Robert Hanselpacker et Julie Marie Hanselpacker par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement du comté de Charlotte le 22 octobre 1999, sous le numéro 10572619, aux pages 355 à 358 du registre 703. Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 7 mars 2012, à 11 h, heure locale, au centre de Services Nouveau-Brunswick, situé au 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 février 2012 du Telegraph-Journal.
Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee. Sale to be held at the Offices of Service New Brunswick located at 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick on the 7th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated February 7, February 14, February 21 and February 28, 2012. McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Nouvelle-Écosse, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095
________________
________________
The Royal Gazette — February 22, 2012
Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Jennifer Audrey Stacey, original Mortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 33 Killarney Road, Riverview, New Brunswick, the same lot conveyed to Jennifer Audrey Stacey by Transfer registered in the Land Titles Office on June 27, 2006, as document number 22329297. Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at Moncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, New Brunswick, on the 2nd day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Times & Transcript dated February 2, February 9, February 16 and February 23, 2012.
315
Gazette royale — 22 février 2012
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Jennifer Audrey Stacey, débitrice hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 33, chemin Killarney, Riverview (NouveauBrunswick), correspondant au même lot ayant été transféré à Jennifer Audrey Stacey par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le 27 juin 2006 sous le numéro 22329297. Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente aura lieu le 2 mars 2012, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville de Moncton, situé au 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times & Transcript.
McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095
________________
________________
Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Preston Fraser Hooper, original Mortgagor; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 336 Route 785, Utopia, New Brunswick, the same lot conveyed to Preston Fraser Hooper by Transfer registered in the Land Titles Office on September 29, 2003, as document number 17142481.
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataire : Preston Fraser Hooper, débiteur hypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 336, route 785, Utopia (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Preston Fraser Hooper par l’acte de transfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le 29 septembre 2003, sous le numéro 17142481. Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente aura lieu le 7 mars 2012, à 11 h 15, heure locale, au centre de Services Nouveau-Brunswick, situé au 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 2, 9, 16 et 23 février 2012 du Times & Transcript.
Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at the Offices of Service New Brunswick located 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick, on the 7th day of March, 2012, at the hour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Times & Transcript dated February 2, February 9, February 16 and February 23, 2012. McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: Mathieu R. Poirier, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095
Mathieu R. Poirier, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banque de Montréal, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506857-4095
________________
________________
Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2) To: Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs, original Mortgagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property being situated at 304 Debec Road, Debec, New Brunswick, the same lot conveyed to Matthew G. Stairs and Shelly L. Stairs by Transfer registered in the Land Titles Office on August 27, 1999, as document number 10444645.
Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonce L.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2) Destinataires : Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs, débiteurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au 304, chemin de Debec, Debec (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré à Matthew G. Stairs et Shelly L. Stairs par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement foncier le 27 août 1999, sous le numéro 10444645.
The Royal Gazette — February 22, 2012
316
Gazette royale — 22 février 2012
Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation as Mortgagee. Sale to be held at the Woodstock Court House located at 689 Main Street, Woodstock, New Brunswick on the 6th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in the Bugle-Observer dated February 7, February 14, February 21 and February 28, 2012.
Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia, créancière hypothécaire. La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h, heure locale, au palais de justice de Woodstock situé au 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 7, 14, 21 et 28 février 2012 du BugleObserver.
McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation, Per: T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street, P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903
T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société hypothécaire Scotia, Barker House, bureau 600, 570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (NouveauBrunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur : 506-458-9903
________________
________________
TO: BRUCE D. HEPPERLE/BRUCE DARWIN HEPPERLE and CAROLE J. HEPPERLE/JEANNINE CAROLE HEPPERLE, of 450 Route 628, Penniac, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagor;
DESTINATAIRES : BRUCE D. HEPPERLE/BRUCE DARWIN HEPPERLE et CAROLE J. HEPPERLE/ JEANNINE CAROLE HEPPERLE, du 450, route 628, Penniac, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires; LA BANQUE ROYALE DU CANADA, 504, rue Queen, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G1, titulaire de la première hypothèque; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 450, route 628, Penniac, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par Secure Capital MIC Inc., titulaire de la deuxième hypothèque. La vente aura lieu le 20 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Fredericton situé au 427, rue Queen, Fredericton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner.
AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 504 Queen Street, Fredericton, New Brunswick, E3G 5G1, Holder of the First Mortgage; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 450 Route 628, Penniac, County of York and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by Secure Capital MIC Inc., holder of a second mortgage. Sale on the 20th day of March, 2012, at the hour of 11:00 a.m., at the Fredericton Court House located at 427 Queen Street, Fredericton, New Brunswick. See advertisement in The Daily Gleaner. MacLean Law, Solicitors for the Mortgagee, Secure Capital MIC Inc.
MacLean Law, avocats du créancier hypothécaire, Secure Capital MIC Inc.
________________
________________
The sale is scheduled for Friday, March 23, 2012, at 11:00 a.m., at the Moncton City Hall, 655 Main Street, Moncton, New Brunswick. See advertisements in the Times & Transcript in the issues of February 22, February 29, March 7 and March 14, 2012.
DESTINATAIRE : JESSIE JAMES SAUNDERS, débiteur hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 11, chemin Leo, Shediac River, comté de Westmorland, province du NouveauBrunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est 70095021. Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTODOMINION. La vente aura lieu le vendredi 23 mars 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des 22 et 29 février et des 7 et 14 mars 2012 du Times & Transcript.
TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSON CREAMER, Per: Robert M. Creamer, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank (TD Canada Trust)
Robert M. Creamer, du cabinet LAWSON & CREAMER, avocats de La Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust)
________________
________________
TO: JESSIE JAMES SAUNDERS, Mortgagor; AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN. Sale conducted under the terms of the first mortgage under the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 11 Leo Road, Shediac River, Westmorland County, Province of New Brunswick and known as Parcel Identifier Number 70095021. Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.
The Royal Gazette — February 22, 2012
To: ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANC ESCALIERS CERAMIQUE LTÉE, 4024 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, Gloucester County and Province of New Brunswick, Mortgagor; CBDC Peninsule Acadienne Inc., subsequent Mortgagee;
317
Gazette royale — 22 février 2012
Sale to be held on the 6th day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Saint-Isidore Municipal Building, located at 3906 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, in the County of Gloucester, New Brunswick. SEE ADVERTISEMENT IN L’ACADIE NOUVELLE.
Destinataire : ST-ISIDORE PLANCHERS BOIS FRANC ESCALIERS CERAMIQUE LTÉE, 4024, boulevard des Fondateurs, à Saint-Isidore, comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire; CBDC Péninsule Acadienne Inc., créancière hypothécaire subséquente; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Bien en tenure libre situé au 4024, boul. des Fondateurs, à Saint-Isidore, dans le comté de Gloucester et province du Nouveau-Brunswick. AVIS DE VENTE donné par la Caisse Populaire Le Lien d’Or Limitée, maintenant connu sous le nom de Caisse populaire le Lien des deux Rivières Ltée suite à une fusion en date du 1er janvier 2012, titulaire de la première hypothèque en vertu du pouvoir de vente contenu dans l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les biens. La vente aura lieu le 6 mars 2012, à 11 h à l’entrée de l’édifice municipal du village de Saint-Isidore, situé au 3906, boulevard des Fondateurs, à Saint-Isidore, dans le comté de Gloucester, au Nouveau-Brunswick. VOIR L’ANNONCE DANS L’ACADIE NOUVELLE.
JONATHAN ROCH NOËL, Solicitor for Caisse Populaire le Lien des deux Rivières Ltée
JONATHAN ROCH NOËL, avocat pour la Caisse Populaire le Lien des deux Rivières Ltée
________________
________________
To: Romain Georges Murray, of the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, and Marie Monique Murray, of the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, Mortgagors; And to: All others whom it may concern. Freehold premises situate, lying and being at 1690 Sunset Drive, in the City of Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, PID 20614665. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage. Sale on the 22nd day of March, 2012, at the hour of 11:00 o’clock in the forenoon, at the Court House in Bathurst, 254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in The Northern Light.
Destinataires : Romain Georges Murray, de la ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, et Marie Monique Murray, de la ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires; Et tout autre intéressé éventuel. Lieux en tenure libre situés au 1690, promenade Sunset, ville de Bathurst, comté de Gloucester, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 20614665. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 22 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Bathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans The Northern Light.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada
________________
________________
TO: DUANE ALEXANDER GEIKIE, of 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Mortgagor; AND TO: EVA GEIKIE, of 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Spouse of Duane Alexander Geikie; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises known as PID 40164014, situate, lying and being at 140 Pond Street, Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder of the first mortgage.
DESTINATAIRES : DUANE ALEXANDER GEIKIE, du 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; EVA GEIKIE, du 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, conjointe de Duane Alexander Geikie; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 140, rue Pond, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification est 40164014. Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titulaire de la première hypothèque.
AND TO ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 4024 des Fondateurs Boulevard, in Saint-Isidore, Gloucester County and Province of New Brunswick. NOTICE OF SALE given by Caisse Populaire Le Lien d’Or Ltee, now known as Caisse populaire le Lien des deux Rivières Ltée following an amalgamation on January 1st, 2012, as Mortgagee and Holder of the First Mortgage by virtue of the power of sale contained in the mortgage and the Property Act.
The Royal Gazette — February 22, 2012
Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the County Court House, 673 King George Highway, Miramichi, New Brunswick. See advertisement in the Miramichi Leader. Sale conducted under the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.
318
Gazette royale — 22 février 2012
DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.
La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice du comté, 673, route King George, Miramichi (NouveauBrunswick). Voir l’annonce publiée dans le Miramichi Leader. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitre P-19. FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.
WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, The Toronto-Dominion Bank
WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire, La Banque Toronto-Dominion
________________
________________
TO: MICHAEL IAN MACKINNON, of 1061 McLeod Hill Road, McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagor; TO: CANADA REVENUE AGENCY, of 126 Prince William Street, Saint John, in the Province of New Brunswick; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises known as PID 75156539, situate, lying and being at 1061 McLeod Hill Road, McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick. Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder of the first mortgage. Sale on the 19th day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Fredericton Court House, 427 Queen Street, in the City of Fredericton, in the County of York, New Brunswick. See advertisement in The Daily Gleaner. Sale conducted under the terms of the mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended. DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, this 31st day of January, 2012.
DESTINATAIRES : MICHAEL IAN MACKINNON, du 1061, chemin de McLeod Hill, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; AGENCE DU REVENU DU CANADA, 126, rue Prince William, Saint John, province du Nouveau-Brunswick; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 1061, chemin de McLeod Hill, McLeod Hill, comté de York, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 75156539. Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 19 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Fredericton, 427, rue Queen, ville de Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans The Daily Gleaner. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, chapitre P-19. FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, le 31 janvier 2012.
WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, The Toronto-Dominion Bank
WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire, La Banque Toronto-Dominion
________________
________________
To: Gary Stephen Siddall and Angela Marie Siddall, of Belleville, in the County of Carleton and Province of New Brunswick, Mortgagors; And to: Royal Bank of Canada, c/o Cox & Palmer, 644 Main Street, Moncton, New Brunswick, E1C 1E2, Judgment Creditor; And to: All others whom it may concern. Freehold premises situate, lying and being at 268 McLellan Road, Belleville, in the County of Carleton and Province of New Brunswick, PID Number 10149342. Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the first mortgage.
Destinataires : Gary Stephen Siddall et Angela Marie Siddall, de Belleville, comté de Carleton, province du NouveauBrunswick, débiteurs hypothécaires; Banque Royale du Canada, a/s de Cox & Palmer, 644, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2, créancière sur jugement; Et tout autre intéressé éventuel. Lieux en tenure libre situés au 268, chemin McLellan, Belleville, comté de Carleton, province du NouveauBrunswick, et dont le NID est 10149342. Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de la première hypothèque.
The Royal Gazette — February 22, 2012
Gazette royale — 22 février 2012
319
Sale on the 21st day of March, 2012, at 11:00 a.m., at the Court House in Woodstock, 689 Main Street, Woodstock, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in The Bugle.
La vente aura lieu le 21 mars 2012, à 11 h, au palais de justice de Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans The Bugle.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank of Canada
Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada
________________
________________
TO: Charles James Donaher, of Targetville, in the County of Kent and Province of New Brunswick, Mortgagor; AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 2710 Route 510, Targetville, in the County of Kent and Province of New Brunswick, also known as PID #25279803. Notice of Sale given by Advance Savings Credit Union Limited (formerly Rexton Credit Union Limited), holder of the first mortgage. Sale on the 4th day of April, 2012, at 11:00 a.m., at the Bouctouche Town Hall, 211 Irving Boulevard, Bouctouche, New Brunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or reschedule the time and date of sale. See advertisement in the Times & Transcript.
DESTINATAIRE : Charles James Donaher, de Targetville, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 2710, route 510, Targetville, comté de Kent, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 25279803. Avis de vente donné par Advance Savings Credit Union Limited (anciennement Rexton Credit Union Limited), titulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le 4 avril 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville de Bouctouche, 211, boulevard Irving, Bouctouche (NouveauBrunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le Times & Transcript.
Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, Advance Savings Credit Union Limited
Cox & Palmer, avocats du créancier hypothécaire, Advance Savings Credit Union Limited
Notice to Advertisers
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’s Printer Office, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Queen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees:
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants :
Notices Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill Originating process Order of a court Notice under the Absconding Debtors Act Notice under the General Rules under the Law Society Act, 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission Notice of examination under the Licensed Practical Nurses Act Notice under the Motor Carrier Act
Cost per Insertion $ 20 $ $ $ $
25 25 20 20
$ 25 $ 30
Avis Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé Acte introductif d’instance Ordonnance rendue par une cour Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite Avis de radiation ou de suspension ou de demande de réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers
Coût par parution 20 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $
25 $ 30 $
The Royal Gazette — February 22, 2012 Any document under the Political Process Financing Act
$ 20
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act
$ 20
Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)
$120
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété
20 $ 20 $ 120 $
(Formule 70B) Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) Notice of a correction
$ 20
Any other document
Gazette royale — 22 février 2012
320
charge is the same as for publishing the original document $3.50 for each cm or less
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) Avis d’une correction
Tout autre document
20 $ 75 $ 20 $ les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations.
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.
The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at:
La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ attorney general/royal gazette.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/ procureur general/gazette royale.html
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13% tax, plus shipping and handling where applicable.
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention.
Office of the Queen’s Printer 670 King Street, Room 117 P.O. Box 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899 E-mail:
[email protected]
Bureau de l’Imprimeur de la Reine 670, rue King, pièce 117 C.P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899 Courriel :
[email protected]
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK
© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés